Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 51 til 100 fra 469

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
51 Trowbridge, Helen Maria  9 mar. 1840Connecticut, USA I51642 AALT 
52 Trowbridge, Abigail  1731Connecticut, USA I8106 AALT 
53 Treadwell, Allen  1791Connecticut, USA I22520 AALT 
54 Tomlinson, Milo  maj 1852Connecticut, USA I136302 AALT 
55 Tomlinson, Clara L.  5 okt. 1858Connecticut, USA I136311 AALT 
56 Tollman, Marion C  1939Connecticut, USA I139761 AALT 
57 Tollman, Marion C  1939Connecticut, USA I69106 AALT 
58 Throop, Hannah  ca. 1773Connecticut, USA I47222 AALT 
59 Thorpe, Justus  ca. 1802Connecticut, USA I74201 AALT 
60 Thompson, Sarah J  ca. 1824Connecticut, USA I72438 AALT 
61 Thomas, Nathan  1814Connecticut, USA I63467 AALT 
62 Thomas, Marshall K  1854Connecticut, USA I63575 AALT 
63 Thomas, Ellen M  1844Connecticut, USA I63685 AALT 
64 Thomas, Constant H  1859Connecticut, USA I63480 AALT 
65 Teater, William A  ca. 1899Connecticut, USA I77460 AALT 
66 Tanner, Walter C.  1875Connecticut, USA I17541 AALT 
67 Tanner, Ruth  1734Connecticut, USA I5212 AALT 
68 Tanner, Rebecca  1691Connecticut, USA I124574 AALT 
69 Tanner, Marinda A.  jul. 1895Connecticut, USA I17358 AALT 
70 Tanner, Margaret E.  jan. 1884Connecticut, USA I17295 AALT 
71 Tanner, John E.  1864Connecticut, USA I29545 AALT 
72 Tanner, Edmund A.  1869Connecticut, USA I16671 AALT 
73 Tallman, Stephen Sr  12 maj 1768Connecticut, USA I139120 AALT 
74 Summers, Martha  1684Connecticut, USA I55377 AALT 
75 Strong, Mary  1779Connecticut, USA I13029 AALT 
76 Strong, Jonathan Q  1768Connecticut, USA I12878 AALT 
77 Strong, Jonathan  1777Connecticut, USA I16446 AALT 
78 Stone, Anna  1850Connecticut, USA I69181 AALT 
79 Stiles, Patty  1782Connecticut, USA I9454 AALT 
80 Stiles, Lucy  1752Connecticut, USA I96139 AALT 
81 Stiles, Jonathan  11 aug. 1780Connecticut, USA I9422 AALT 
82 Stevens, Moses  Connecticut, USA I120 AALT 
83 Sterling, Sally  1715Connecticut, USA I13480 AALT 
84 Stannis, Frank A.  23 maj 1869Connecticut, USA I115063 AALT 
85 Stannis, Charles Edward  1842Connecticut, USA I90977 AALT 
86 Stannard, Mary  ca. 1755Connecticut, USA I92541 AALT 
87 Stacy, Susan Ann  1657Connecticut, USA I18236 AALT 
88 Spencer, Mary  11 okt. 1780Connecticut, USA I12824 AALT 
89 Spencer, Martha  1 sep. 1745Connecticut, USA I27087 AALT 
90 Spencer, Jane  1735Connecticut, USA I21119 AALT 
91 Spencer, Hannah  1784Connecticut, USA I12747 AALT 
92 Spencer, Eldad  1730Connecticut, USA I12930 AALT 
93 Spencer, Child  1793Connecticut, USA I15628 AALT 
94 Spencer, Catherine  1778Connecticut, USA I11394 AALT 
95 Smith, Sally Denison  28 aug. 1779Connecticut, USA I35812 AALT 
96 Smith, Nathaniel Roswell  24 nov. 1778Connecticut, USA I61018 AALT 
97 Smith, Lucretia  1786Connecticut, USA I23757 AALT 
98 Smith, Deborah  1711Connecticut, USA I61683 AALT 
99 Slate Mr.  1720Connecticut, USA I27110 AALT 
100 Siner, Harriett Jane  8 jan. 1910Connecticut, USA I111910 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Næste»



Død

Match 51 til 100 fra 273

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
51 Pratt, Sarah  5 dec. 1833Connecticut, USA I94557 AALT 
52 Pratt, Nn  1790Connecticut, USA I20217 AALT 
53 Pratt, Nn  1790Connecticut, USA I16058 AALT 
54 Pratt, Nathaniel  1744Connecticut, USA I165 AALT 
55 Pratt, David Jr.  eft. 1766Connecticut, USA I38999 AALT 
56 Pratt, Cynthia  29 aug. 1856Connecticut, USA I100615 AALT 
57 Porter, Experience  28 okt. 1744Connecticut, USA I57556 AALT 
58 Phelps, Sarah  30 nov. 1827Connecticut, USA I62257 AALT 
59 Phelps, Mehitable  1752Connecticut, USA I126947 AALT 
60 Phelps, Charles E.  22 maj 1833Connecticut, USA I102585 AALT 
61 Phelps, Alexander  1773Connecticut, USA I126942 AALT 
62 Perkins, Polydore  19 nov. 1800Connecticut, USA I4461 AALT 
63 Perkins, John  1800Connecticut, USA I23673 AALT 
64 Pember, Jane King  9 dec. 1909Connecticut, USA I65860 AALT 
65 Peet, Abijah  1782Connecticut, USA I93841 AALT 
66 Peck, Samuel  26 apr. 1888Connecticut, USA I37647 AALT 
67 Peck, Ruth  29 mar. 1728Connecticut, USA I46391 AALT 
68 Peck, Pamelia  1878Connecticut, USA I39196 AALT 
69 Peck, Mary  13 aug. 1863Connecticut, USA I37531 AALT 
70 Peck, Martha "Patty"  10 aug. 1891Connecticut, USA I37624 AALT 
71 Pattee, Susan E.  28 jun. 1998Connecticut, USA I68561 AALT 
72 Partridge, William  2 okt. 1836Connecticut, USA I40293 AALT 
73 Palmer, Thankful  Connecticut, USA I4448 AALT 
74 Palmer, Sarah  Connecticut, USA I124677 AALT 
75 Palmer, Judith  Connecticut, USA I4653 AALT 
76 Palmer, Edward  Connecticut, USA I4677 AALT 
77 Paine, Ezra  27 okt. 1811Connecticut, USA I25554 AALT 
78 Paine, Deborah  1800Connecticut, USA I39983 AALT 
79 North, Sarah Maria  1935Connecticut, USA I67202 AALT 
80 Mygatt, Webster  5 maj 1760Connecticut, USA I79506 AALT 
81 Mygatt, Jonathon  1785Connecticut, USA I79476 AALT 
82 Mudge, Ann  Connecticut, USA I40355 AALT 
83 Morgan, Theophilus Sr.  22 nov. 1766Connecticut, USA I136329 AALT 
84 Morgan, Daniel  16 okt. 1773Connecticut, USA I135785 AALT 
85 Morehouse, Mary  14 mar. 1697Connecticut, USA I46213 AALT 
86 Moore, Col. Samuel A.  11 maj 1912Connecticut, USA I65982 AALT 
87 Mitchell, Elizabeth  1670Connecticut, USA I40987 AALT 
88 Miner, Joseph Latham  7 sep. 1894Connecticut, USA I96002 AALT 
89 Millington, John  8 jul. 1740Connecticut, USA I72972 AALT 
90 Millington, Catherine  1978Connecticut, USA I134445 AALT 
91 Metcalfe, Simeon  26 okt. 1773Connecticut, USA I26966 AALT 
92 Messenger, Sarah  1685Connecticut, USA I5150 AALT 
93 Merriam, James  eft. nov. 1830Connecticut, USA I31996 AALT 
94 Matson, Amy  1820Connecticut, USA I11475 AALT 
95 Mason, Mary  Connecticut, USA I45557 AALT 
96 Marvin, Martha  21 jun. 1930Connecticut, USA I126248 AALT 
97 Marsh, Maria  8 feb. 1881Connecticut, USA I65703 AALT 
98 Mansfield, Samuel  12 dec. 1705Connecticut, USA I137617 AALT 
99 Manning, Sarah Rose  21 feb. 1918Connecticut, USA I62695 AALT 
100 MacOon, Mary  1784Connecticut, USA I66300 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»



Begravelse

Match 51 til 83 fra 83

«Forrige 1 2

   Efternavn, Fornavn    Begravelse    Person-ID   Træ 
51 Griswold, Josiah  1800Connecticut, USA I9783 AALT 
52 Griswold, Jerusha  mar. 1745Connecticut, USA I124958 AALT 
53 Gardiner, Elizabeth  Connecticut, USA I61174 AALT 
54 Dodge, Stephen  1809Connecticut, USA I60782 AALT 
55 Dodge, Daniel  Connecticut, USA I10638 AALT 
56 De Wolf, Simon  1704Connecticut, USA I13173 AALT 
57 Davis, Sarah  Connecticut, USA I117804 AALT 
58 Cooper, Sarah  1711Connecticut, USA I62158 AALT 
59 Cook, Mary F.  Connecticut, USA I63447 AALT 
60 Cook, Frances L.  Connecticut, USA I63430 AALT 
61 Cook, Catharine  Connecticut, USA I63274 AALT 
62 Conant, Hannah  Connecticut, USA I29429 AALT 
63 Clark, Isaac  1744Connecticut, USA I1856 AALT 
64 Bull, Cornelius W  Connecticut, USA I64209 AALT 
65 Brewster, William Mansfield  Connecticut, USA I12917 AALT 
66 Brewster, William  nov. 1726Connecticut, USA I12774 AALT 
67 Brewster, Hannah  Connecticut, USA I15621 AALT 
68 Brewster, Elisha  1746Connecticut, USA I12709 AALT 
69 Brewster, Elisha  Connecticut, USA I136319 AALT 
70 Brewster, Anne  jan. 1776Connecticut, USA I136318 AALT 
71 Brewster, Anne  jan. 1776Connecticut, USA I125176 AALT 
72 Brewster, Abel  Connecticut, USA I12671 AALT 
73 Bixby, Benjamin  dec. 1744Connecticut, USA I29292 AALT 
74 Bissell, Abigail  Connecticut, USA I31426 AALT 
75 Birchard, Hannah  Connecticut, USA I72597 AALT 
76 Bingham, Daniel  1 feb. 1805Connecticut, USA I29099 AALT 
77 Belden, John  jun. 1677Connecticut, USA I62606 AALT 
78 Armstrong, Peletiah  Connecticut, USA I9148 AALT 
79 Adams, William  Connecticut, USA I11122 AALT 
80 Adams, Lois  maj 1821Connecticut, USA I11013 AALT 
81 Adams, James  Connecticut, USA I11085 AALT 
82 Abell, Mehitable  Connecticut, USA I134790 AALT 
83 Abell, Mehitable  Connecticut, USA I27075 AALT 

«Forrige 1 2



Ægteskab

Match 51 til 99 fra 99

«Forrige 1 2

   Familie    Ægteskab    Familie-ID   Træ 
51 Judd / Brown  1926Connecticut, USA F13200 AALT 
52 Huntington / Bibbens  23 feb. 1823Connecticut, USA F4895 AALT 
53 Humphrey / Bidwell  1808Connecticut, USA F14186 AALT 
54 Hull / Foster  Connecticut, USA F24860 AALT 
55 Hubbell / Tuttle  1891Connecticut, USA F12217 AALT 
56 Hopkins / Hotchkiss  9 jun. 1861Connecticut, USA F12154 AALT 
57 Hooker / Hamlin  28 jun. 1687Connecticut, USA F32185 AALT 
58 Hodge / Russell  1725Connecticut, USA F269 AALT 
59 Hodge / Elwell  nov. 1778Connecticut, USA F287 AALT 
60 Hitchcock / Sedgwick  21 aug. 1846Connecticut, USA F12962 AALT 
61 Hemingway / Talmadge  11 nov. 1713Connecticut, USA F2881 AALT 
62 Hemingway / Smith  1807Connecticut, USA F2996 AALT 
63 Hemingway / Hinman  1820Connecticut, USA F2995 AALT 
64 Hayes / Roland  1769Connecticut, USA F18105 AALT 
65 Gillette / Williams  1 jun. 1886Connecticut, USA F26930 AALT 
66 Fuller / Beckwith  ca. 1737Connecticut, USA F15553 AALT 
67 Friend / Tuttle  1913Connecticut, USA F12251 AALT 
68 Flint / Hawes  1797Connecticut, USA F23791 AALT 
69 Fillmore / Carrier  1732Connecticut, USA F1906 AALT 
70 Filleau / Stevens  29 dec. 1703Connecticut, USA F18242 AALT 
71 Elwell / Jones  Connecticut, USA F228 AALT 
72 Drake / Sadd  ca. 1770Connecticut, USA F9733 AALT 
73 Dorman / Sperry  23 apr. 1724Connecticut, USA F811 AALT 
74 Dodge / Gardiner  1769Connecticut, USA F11527 AALT 
75 Dewolf / Little  1756Connecticut, USA F7944 AALT 
76 Cutler / Stebbins  1810Connecticut, USA F3587 AALT 
77 Clark / Keeler  3 maj 1802Connecticut, USA F15771 AALT 
78 Case / Moore  3 nov. 1691Connecticut, USA F10972 AALT 
79 Carrington / Kirtland  22 sep. 1812Connecticut, USA F11986 AALT 
80 Burnham / Williams  27 maj 1738Connecticut, USA F4513 AALT 
81 Bristol / Humphrey  30 mar. 1904Connecticut, USA F13555 AALT 
82 Brewster / Sweatland  30 mar. 1749Connecticut, USA F24047 AALT 
83 Brewster / Ketchem  ca. 1847Connecticut, USA F30220 AALT 
84 Brainerd / Pattee  30 aug. 1898Connecticut, USA F12239 AALT 
85 Bixby / Hammond  ca. 1753Connecticut, USA F181 AALT 
86 Bitgood / Pratt  12 jan. 1852Connecticut, USA F19491 AALT 
87 Bishop / Peck  27 jul. 1870Connecticut, USA F12009 AALT 
88 Bingham / Waldo  21 sep. 1814Connecticut, USA F5765 AALT 
89 Bidwell / Stone  1870Connecticut, USA F14546 AALT 
90 Bidwell / Hotchkiss  1810Connecticut, USA F13339 AALT 
91 Bidwell / Graham  1824Connecticut, USA F13552 AALT 
92 Bidwell / Gilman  1733Connecticut, USA F2179 AALT 
93 Bidwell / Burr  10 maj 1882Connecticut, USA F13578 AALT 
94 Belty / Carpenter  1761Connecticut, USA F7515 AALT 
95 Beckwith / Harvey  ca. 1730Connecticut, USA F15448 AALT 
96 Beckwith / Fuller  ca. 1796Connecticut, USA F15518 AALT 
97 Babcock / Fuller  1814Connecticut, USA F7364 AALT 
98 Austin / Yale  1865Connecticut, USA F12222 AALT 
99 Andros / Sampson  1779Connecticut, USA F30509 AALT 

«Forrige 1 2



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.