Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 401 til 450 fra 469

«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
401 Austin, Lucy R.  1878Connecticut, USA I63429 AALT 
402 Moore, Roberta E.  feb. 1878Connecticut, USA I65704 AALT 
403 Tuttle, Mary E  1879Connecticut, USA I67424 AALT 
404 Yale, Fred Thomas Jr  31 maj 1879Connecticut, USA I74418 AALT 
405 Ireland, Sarah Coe  1880Connecticut, USA I87938 AALT 
406 Munson, Henry Hallet  3 feb. 1880Connecticut, USA I78127 AALT 
407 Humphrey, Emma Louise  12 apr. 1881Connecticut, USA I67245 AALT 
408 Besse, Gertrude Louisa  22 apr. 1881Connecticut, USA I41038 AALT 
409 Birge, Louise M  1 apr. 1882Connecticut, USA I65403 AALT 
410 Griffin, Mary L.  ca. 1884Connecticut, USA I40557 AALT 
411 Tanner, Margaret E.  jan. 1884Connecticut, USA I17295 AALT 
412 Humphrey, Helen G  jun. 1884Connecticut, USA I67078 AALT 
413 Osborne, K Gertrude  9 sep. 1884Connecticut, USA I62269 AALT 
414 Burnham, Philip Theodore  1885Connecticut, USA I66771 AALT 
415 Mitchell, Basil K  1885Connecticut, USA I68128 AALT 
416 Fowler, Mabel E  jun. 1885Connecticut, USA I62993 AALT 
417 Yale, Son  1886Connecticut, USA I63080 AALT 
418 Bitgood, Mary Josephine  14 jun. 1886Connecticut, USA I84609 AALT 
419 Jennings, Ethel M.  okt. 1886Connecticut, USA I136261 AALT 
420 Brigham, Barbara L  nov. 1888Connecticut, USA I40190 AALT 
421 Fowler, Ethel B  dec. 1888Connecticut, USA I63046 AALT 
422 Norton, Willis Henry  14 jul. 1890Connecticut, USA I67151 AALT 
423 Bidwell, Lena Belle  jun. 1891Connecticut, USA I66901 AALT 
424 Brewster, Ruth  14 jul. 1893Connecticut, USA I136309 AALT 
425 Griswald, Anita  1895Connecticut, USA I67278 AALT 
426 Judd, Alice Lucile  1895Connecticut, USA I66008 AALT 
427 Tanner, Marinda A.  jul. 1895Connecticut, USA I17358 AALT 
428 Bitgood, Rose Evelyn  1896Connecticut, USA I84546 AALT 
429 Fowler, Helen P  maj 1896Connecticut, USA I62766 AALT 
430 Hall, Mabel H  mar. 1898Connecticut, USA I63308 AALT 
431 Buren, Myron Van  5 jul. 1898Connecticut, USA I71903 AALT 
432 Teater, William A  ca. 1899Connecticut, USA I77460 AALT 
433 Goodenough, Dorothy  1900Connecticut, USA I65811 AALT 
434 Wallace, Barbara Manning  24 maj 1900Connecticut, USA I63050 AALT 
435 McGowan, Harriet C.  2 sep. 1900Connecticut, USA I63230 AALT 
436 Goodenough, Frieda M  1903Connecticut, USA I65408 AALT 
437 Honor, Josephine  1903Connecticut, USA I67304 AALT 
438 Hubbell, Mabel T.  1903Connecticut, USA I63251 AALT 
439 Marshall, Beatrice  1903Connecticut, USA I67894 AALT 
440 Bristol, Sarah Elizabeth  1904Connecticut, USA I67215 AALT 
441 Goodenough, Barbara A  1904Connecticut, USA I65825 AALT 
442 Hills, Truman Clark  1904Connecticut, USA I67207 AALT 
443 Kerr, Henry Stewart  1904Connecticut, USA I67231 AALT 
444 Siner, Ethel Irma  21 mar. 1906Connecticut, USA I111865 AALT 
445 Brainard, Mary Louise  23 mar. 1908Connecticut, USA I63523 AALT 
446 Tuttle, Paul Whitney  14 jul. 1908Connecticut, USA I75309 AALT 
447 Bidwell, Ruth Wagner  18 sep. 1908Connecticut, USA I67402 AALT 
448 Barnes, Marjorie  1909Connecticut, USA I67437 AALT 
449 Barnes, Wilbur J  1909Connecticut, USA I67333 AALT 
450 Goodenough, Virginia A  1909Connecticut, USA I65848 AALT 

«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Næste»



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.