Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 251 til 300 fra 469

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
251 Hubbard, Elijah  1793Connecticut, USA I91883 AALT 
252 Howard, Lois  1775Connecticut, USA I41459 AALT 
253 Hough, Jennie Blakeslee  5 jan. 1864Connecticut, USA I63319 AALT 
254 Hotchkiss, Roswell  1806Connecticut, USA I63493 AALT 
255 Hotchkiss, Edgar Eugene  1843Connecticut, USA I63400 AALT 
256 Hopkins, Sarah  ca. 1750Connecticut, USA I30943 AALT 
257 Hopkins, Emily A.  17 apr. 1862Connecticut, USA I63108 AALT 
258 Hooker, Susannah  1688Connecticut, USA I143862 AALT 
259 Hooker, Ruth  16 apr. 1708Connecticut, USA I143840 AALT 
260 Honor, Josephine  1903Connecticut, USA I67304 AALT 
261 Honer, Martin Joseph  1875Connecticut, USA I62510 AALT 
262 Holmes, Mariva E  1816Connecticut, USA I62197 AALT 
263 Holcomb, Deborah  10 feb. 1673Connecticut, USA I32048 AALT 
264 Hogarty, Mary Emily  28 sep. 1863Connecticut, USA I96219 AALT 
265 Hodges, Rebecca  1751Connecticut, USA I71 AALT 
266 Hitchcock, Jane  5 maj 1812Connecticut, USA I78650 AALT 
267 Hinckley, Sallie  1785Connecticut, USA I95575 AALT 
268 Hinckley, Polly  1779Connecticut, USA I95471 AALT 
269 Hinckley, Patty  1781Connecticut, USA I95583 AALT 
270 Hinckley, Henry  1777Connecticut, USA I95613 AALT 
271 Hinckley, Charlotte  1783Connecticut, USA I95641 AALT 
272 Hills, Truman Clark  1904Connecticut, USA I67207 AALT 
273 Heminway, Sarah  1773Connecticut, USA I34199 AALT 
274 Hemingway, Samuel S  1827Connecticut, USA I9922 AALT 
275 Hemingway, Betsey  1834Connecticut, USA I16369 AALT 
276 Hathaway, Orson B  22 maj 1808Connecticut, USA I43545 AALT 
277 Harvey, Hope R.  1926Connecticut, USA I65660 AALT 
278 Hamlin, Mehitabel  17 nov. 1664Connecticut, USA I143854 AALT 
279 Hamersly, Lewis Randolph  ca. 1842Connecticut, USA I96888 AALT 
280 Hall, Mabel H  mar. 1898Connecticut, USA I63308 AALT 
281 Hall, Lucy A  1813Connecticut, USA I62863 AALT 
282 Hall, Isaac Kirtland  20 mar. 1809Connecticut, USA I63356 AALT 
283 Hall, Gertrude Ellen  1926Connecticut, USA I63340 AALT 
284 Hall, David S  1927Connecticut, USA I63180 AALT 
285 Hall, David M.  27 maj 1818Connecticut, USA I63122 AALT 
286 Hall, Dalia Charlotte  6 okt. 1815Connecticut, USA I63334 AALT 
287 Hall, Catherine L  1924Connecticut, USA I63401 AALT 
288 Hall, Abel L  6 mar. 1815Connecticut, USA I72389 AALT 
289 Haires, Caroline B  1801Connecticut, USA I91242 AALT 
290 Gurnsey, Samantha  nov. 1787Connecticut, USA I94639 AALT 
291 Griswald, Anita  1895Connecticut, USA I67278 AALT 
292 Griffin, Mary L.  ca. 1884Connecticut, USA I40557 AALT 
293 Griffin, Abigail  24 maj 1761Connecticut, USA I57876 AALT 
294 Gould, Cora D.  1856Connecticut, USA I79263 AALT 
295 Goodwin, Isaac  17 apr. 1733Connecticut, USA I127457 AALT 
296 Goodenough, Virginia A  1909Connecticut, USA I65848 AALT 
297 Goodenough, Frieda M  1903Connecticut, USA I65408 AALT 
298 Goodenough, Dorothy  1900Connecticut, USA I65811 AALT 
299 Goodenough, Barbara A  1904Connecticut, USA I65825 AALT 
300 Goodenough, Arthur Griswold  27 apr. 1911Connecticut, USA I65940 AALT 

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»



Død

Match 251 til 273 fra 273

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
251 Beach, Mary  1 sep. 1688Connecticut, USA I42281 AALT 
252 Beach, Esther  12 dec. 1772Connecticut, USA I42328 AALT 
253 Bartlett Jr., Samuel Jr.  19 nov. 1746Connecticut, USA I113631 AALT 
254 Barrett, Susannah  4 jan. 1749Connecticut, USA I71285 AALT 
255 Barrett, Phebe  13 jan. 1749Connecticut, USA I72435 AALT 
256 Barden, Sarah  28 feb. 1818Connecticut, USA I73276 AALT 
257 Balch, Thomas  1 jul. 1871Connecticut, USA I62802 AALT 
258 Badger, Sarah  19 jul. 1847Connecticut, USA I29953 AALT 
259 Babcock, Phebe  1841Connecticut, USA I95222 AALT 
260 Babcock, Ezera  Connecticut, USA I33693 AALT 
261 Avery, James  1763Connecticut, USA I75631 AALT 
262 Atwater, Hannah  1825Connecticut, USA I51273 AALT 
263 Atkins, Zilpah  26 jan. 1787Connecticut, USA I28717 AALT 
264 Atkins, Mary  eft. 1760Connecticut, USA I100367 AALT 
265 Arnold, Rhodes  22 jun. 1812Connecticut, USA I74950 AALT 
266 Arnold, Amy  19 sep. 1797Connecticut, USA I74799 AALT 
267 Andrews, Harriet Gordon  24 okt. 1902Connecticut, USA I96427 AALT 
268 Alling, Ebenezer  18 sep. 1734Connecticut, USA I140296 AALT 
269 Allen, Capt. Capt. Thomas  16 maj 1842Connecticut, USA I35825 AALT 
270 Adams, William  21 maj 1821Connecticut, USA I11122 AALT 
271 Adams, Lois  21 maj 1821Connecticut, USA I11013 AALT 
272 Adams, James  Connecticut, USA I11085 AALT 
273 Adams, Elizabeth  20 mar. 1781Connecticut, USA I26706 AALT 

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.