Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 251 til 300 fra 469

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
251 Hathaway, Orson B  22 maj 1808Connecticut, USA I43545 AALT 
252 Emmons, Amanda  1809Connecticut, USA I20643 AALT 
253 Hall, Isaac Kirtland  20 mar. 1809Connecticut, USA I63356 AALT 
254 Hubbard, Timothy B  1810Connecticut, USA I94616 AALT 
255 Pratt, Maria  1810Connecticut, USA I94520 AALT 
256 Seaman, Sellinda  1810Connecticut, USA I46873 AALT 
257 Brace, Edmund  1811Connecticut, USA I41632 AALT 
258 Seymour, George  1811Connecticut, USA I136299 AALT 
259 Bibbins, Maria  nov. 1811Connecticut, USA I13567 AALT 
260 Edwards, George William  1 nov. 1811Connecticut, USA I75242 AALT 
261 Hitchcock, Jane  5 maj 1812Connecticut, USA I78650 AALT 
262 Cary, Lucius Henry  1813Connecticut, USA I33062 AALT 
263 Hall, Lucy A  1813Connecticut, USA I62863 AALT 
264 Kingsley, Eleanor Mariah  28 jan. 1813Connecticut, USA I108920 AALT 
265 Loomis, Martha Wadsworth  26 okt. 1813Connecticut, USA I136334 AALT 
266 Thomas, Nathan  1814Connecticut, USA I63467 AALT 
267 Humphrey, George Frederick  11 feb. 1814Connecticut, USA I67104 AALT 
268 Kingsley, Harriet  3 mar. 1814Connecticut, USA I108918 AALT 
269 Hall, Abel L  6 mar. 1815Connecticut, USA I72389 AALT 
270 Seymour, Ann Maria  10 jul. 1815Connecticut, USA I65580 AALT 
271 Hall, Dalia Charlotte  6 okt. 1815Connecticut, USA I63334 AALT 
272 Babcock, Lucy Bell  1816Connecticut, USA I84855 AALT 
273 Holmes, Mariva E  1816Connecticut, USA I62197 AALT 
274 Parsons, Mary Ann  1816Connecticut, USA I63778 AALT 
275 Seymour, Wellington  1816Connecticut, USA I65371 AALT 
276 Babcock, William D  1 maj 1816Connecticut, USA I56492 AALT 
277 Bidwell, Erastus Frank  13 dec. 1816Connecticut, USA I67058 AALT 
278 Cook, Jane  1817Connecticut, USA I63205 AALT 
279 Shelden, Adeline  1817Connecticut, USA I43799 AALT 
280 Shepard, Caleb A.  1818Connecticut, USA I14126 AALT 
281 Hall, David M.  27 maj 1818Connecticut, USA I63122 AALT 
282 Benson, Henry Edward  1819Connecticut, USA I65969 AALT 
283 Dunning, Charity  1819Connecticut, USA I81063 AALT 
284 Seymour  1819Connecticut, USA I65635 AALT 
285 Merriman, George Isaac  20 feb. 1820Connecticut, USA I72459 AALT 
286 Fayrweather, Joseph B.  1821Connecticut, USA I76802 AALT 
287 Fish, Lydia B  1821Connecticut, USA I46964 AALT 
288 Seymour, Roswell  1821Connecticut, USA I65796 AALT 
289 Young, Orrin  ca. 1822Connecticut, USA I84512 AALT 
290 Pratt, William Lee  29 aug. 1823Connecticut, USA I118332 AALT 
291 Bidwell, Mrs Rhoda  1824Connecticut, USA I66887 AALT 
292 Thompson, Sarah J  ca. 1824Connecticut, USA I72438 AALT 
293 Wilcox, Elizabeth M  1 apr. 1824Connecticut, USA I84812 AALT 
294 Beckwith, Oliver Allyn  nov. 1824Connecticut, USA I72534 AALT 
295 Avery, Wheeler  1826Connecticut, USA I29989 AALT 
296 Beckwith, Mary Ann  ca. 1826Connecticut, USA I72710 AALT 
297 Hemingway, Samuel S  1827Connecticut, USA I9922 AALT 
298 Beckwith, Samuel J  ca. 1828Connecticut, USA I72537 AALT 
299 Burnham, William Wallace  14 apr. 1828Connecticut, USA I73295 AALT 
300 Moore, Mrs Lucy  1829Connecticut, USA I65828 AALT 

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»



Død

Match 251 til 273 fra 273

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
251 Bixby, Joseph Edward  12 okt. 1905Connecticut, USA I38111 AALT 
252 Bidwell, Frederick Albert  1907Connecticut, USA I67274 AALT 
253 Pember, Jane King  9 dec. 1909Connecticut, USA I65860 AALT 
254 Hogarty, Mary Emily  17 aug. 1910Connecticut, USA I96219 AALT 
255 Tanner, William Warren  23 aug. 1911Connecticut, USA I80570 AALT 
256 Moore, Col. Samuel A.  11 maj 1912Connecticut, USA I65982 AALT 
257 Elwell, Angeline  9 maj 1914Connecticut, USA I10700 AALT 
258 Seaman, Jane E.  1918Connecticut, USA I51274 AALT 
259 Manning, Sarah Rose  21 feb. 1918Connecticut, USA I62695 AALT 
260 Bidwell, George Edmund  1922Connecticut, USA I69110 AALT 
261 Bidwell, Grove Sherman  1926Connecticut, USA I67343 AALT 
262 Tanner, Luther S.  1927Connecticut, USA I80674 AALT 
263 Judd, Nancy  27 okt. 1927Connecticut, USA I65786 AALT 
264 Marvin, Martha  21 jun. 1930Connecticut, USA I126248 AALT 
265 Hemingway, Willis J.  4 nov. 1931Connecticut, USA I14814 AALT 
266 North, Sarah Maria  1935Connecticut, USA I67202 AALT 
267 Bitgood, Frederick Ellsworth  21 jan. 1938Connecticut, USA I96107 AALT 
268 Goodenough, Priscilla Pauline  25 nov. 1959Connecticut, USA I65847 AALT 
269 Goodenough, Giles Frederick  jan. 1960Connecticut, USA I65816 AALT 
270 Hart, Lena May  1963Connecticut, USA I67235 AALT 
271 Millington, Catherine  1978Connecticut, USA I134445 AALT 
272 Brainard, Mary Louise  28 sep. 1989Connecticut, USA I63523 AALT 
273 Pattee, Susan E.  28 jun. 1998Connecticut, USA I68561 AALT 

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.