Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 101 til 150 fra 469

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
101 Stannard, Mary  ca. 1755Connecticut, USA I92541 AALT 
102 Allen, Capt. Capt. Thomas  10 sep. 1755Connecticut, USA I35825 AALT 
103 Drake, Anne  1758Connecticut, USA I55789 AALT 
104 Humason, Joel  1758Connecticut, USA I1157 AALT 
105 Peet, Abijah  1759Connecticut, USA I93841 AALT 
106 Wasson, John  9 maj 1759Connecticut, USA I21442 AALT 
107 Millard, Abiathar  14 sep. 1760Connecticut, USA I3601 AALT 
108 Barker, Col. Edward  1761Connecticut, USA I62520 AALT 
109 Richards, Moses  1761Connecticut, USA I54080 AALT 
110 Griffin, Abigail  24 maj 1761Connecticut, USA I57876 AALT 
111 Ford, Elijah  ca. 1762Connecticut, USA I110042 AALT 
112 Newcomb, Lydia  28 apr. 1763Connecticut, USA I121040 AALT 
113 Angel, Joshua  1764Connecticut, USA I192 AALT 
114 Gates, Israel  1764Connecticut, USA I28945 AALT 
115 Chalker, Sarah 'Sally'  15 jul. 1764Connecticut, USA I49253 AALT 
116 Wilcox, Mary  1765Connecticut, USA I127806 AALT 
117 Rudd, Betsy Betty  28 jun. 1765Connecticut, USA I10494 AALT 
118 Hull, Sarah  7 okt. 1765Connecticut, USA I117623 AALT 
119 Bierce, Martha  1766Connecticut, USA I98915 AALT 
120 Strong, Jonathan Q  1768Connecticut, USA I12878 AALT 
121 Tallman, Stephen Sr  12 maj 1768Connecticut, USA I139120 AALT 
122 Brewster, Paul  1769Connecticut, USA I57091 AALT 
123 Lancraft, Mary  ca. 1769Connecticut, USA I117616 AALT 
124 Rose, Jerusha  ca. 1770Connecticut, USA I136333 AALT 
125 Picket, Eli  26 apr. 1770Connecticut, USA I88439 AALT 
126 Bixby, Chloe  ca. 1771Connecticut, USA I38087 AALT 
127 Mnu, Jerusha  1771Connecticut, USA I42368 AALT 
128 Rose, Daniel  1771Connecticut, USA I136332 AALT 
129 Pember, Lois  1772Connecticut, USA I14717 AALT 
130 Rice, Miriam  ca. 1772Connecticut, USA I41767 AALT 
131 Rude, Mehitable  1772Connecticut, USA I10109 AALT 
132 Wightman, Lucy  17 maj 1772Connecticut, USA I125920 AALT 
133 Brewster, John  1773Connecticut, USA I15386 AALT 
134 Foster, Elizabeth  1773Connecticut, USA I117632 AALT 
135 Heminway, Sarah  1773Connecticut, USA I34199 AALT 
136 Throop, Hannah  ca. 1773Connecticut, USA I47222 AALT 
137 Cornwall, Mehitable  7 apr. 1773Connecticut, USA I60951 AALT 
138 Brown, Rusel  1774Connecticut, USA I16752 AALT 
139 Gates, Daniel  1774Connecticut, USA I4445 AALT 
140 D'wolf, Martha  13 maj 1774Connecticut, USA I15231 AALT 
141 Brewster, Alexander  1775Connecticut, USA I15404 AALT 
142 Howard, Lois  1775Connecticut, USA I41459 AALT 
143 Keith, Barbara  eft. 1774Connecticut, USA I43534 AALT 
144 Keith, Elizabeth  eft. 1774Connecticut, USA I43694 AALT 
145 Wightman, William D  1775Connecticut, USA I46681 AALT 
146 Lathrop, Mary Polly  9 jan. 1776Connecticut, USA I74544 AALT 
147 Hinckley, Henry  1777Connecticut, USA I95613 AALT 
148 Markham, William  1777Connecticut, USA I31646 AALT 
149 Strong, Jonathan  1777Connecticut, USA I16446 AALT 
150 Markham, Daniel  1778Connecticut, USA I31635 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Næste»



Død

Match 101 til 150 fra 273

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
101 Loomis, Ruth  17 jun. 1770Connecticut, USA I5201 AALT 
102 Bixby, John  2 sep. 1770Connecticut, USA I16372 AALT 
103 Ward, Diantha  1771Connecticut, USA I21936 AALT 
104 Elliot, Mary  9 mar. 1771Connecticut, USA I143811 AALT 
105 Beach, Esther  12 dec. 1772Connecticut, USA I42328 AALT 
106 Phelps, Alexander  1773Connecticut, USA I126942 AALT 
107 Morgan, Daniel  16 okt. 1773Connecticut, USA I135785 AALT 
108 Metcalfe, Simeon  26 okt. 1773Connecticut, USA I26966 AALT 
109 Brewster, John  28 aug. 1774Connecticut, USA I13371 AALT 
110 Hall, Sarah  5 sep. 1774Connecticut, USA I66316 AALT 
111 Russell, Abigail  1775Connecticut, USA I18162 AALT 
112 Dodge, John  aug. 1775Connecticut, USA I71835 AALT 
113 Brewster, Anne  28 jan. 1776Connecticut, USA I136318 AALT 
114 Brewster, Anne  28 jan. 1776Connecticut, USA I125176 AALT 
115 Freeman, Sylvanus  29 maj 1776Connecticut, USA I37014 AALT 
116 Mack, John Lieat  17 okt. 1778Connecticut, USA I87021 AALT 
117 Ellsworth, Capt. John  14 jul. 1779Connecticut, USA I11303 AALT 
118 Chesebrough, Priscilla  1780Connecticut, USA I117693 AALT 
119 Burnham, Eleanor  8 apr. 1780Connecticut, USA I46236 AALT 
120 Beckwith, Job  15 dec. 1780Connecticut, USA I72431 AALT 
121 Adams, Elizabeth  20 mar. 1781Connecticut, USA I26706 AALT 
122 Peet, Abijah  1782Connecticut, USA I93841 AALT 
123 Cartwright, Nicholas  24 maj 1782Connecticut, USA I72374 AALT 
124 Sampson, Priscilla Andrus  25 apr. 1783Connecticut, USA I135728 AALT 
125 MacOon, Mary  1784Connecticut, USA I66300 AALT 
126 Hodge, Rhoda  10 aug. 1784Connecticut, USA I5300 AALT 
127 Mygatt, Jonathon  1785Connecticut, USA I79476 AALT 
128 Gray, Anstrase  11 jun. 1785Connecticut, USA I19807 AALT 
129 Atkins, Zilpah  26 jan. 1787Connecticut, USA I28717 AALT 
130 Kimball, Elijah  4 nov. 1788Connecticut, USA I95177 AALT 
131 Drake, David  1790Connecticut, USA I103117 AALT 
132 Pratt, Nn  1790Connecticut, USA I20217 AALT 
133 Pratt, Nn  1790Connecticut, USA I16058 AALT 
134 Drake, Job  3 apr. 1790Connecticut, USA I107397 AALT 
135 Seymour, Thankful  jun. 1790Connecticut, USA I66656 AALT 
136 Denison, Samuel  10 mar. 1792Connecticut, USA I22162 AALT 
137 Kneeland, Phebe  26 apr. 1793Connecticut, USA I61031 AALT 
138 Chipman, Thomas  28 mar. 1795Connecticut, USA I124913 AALT 
139 Hull, Sarah  1 feb. 1796Connecticut, USA I117807 AALT 
140 Hooker, Hannah  21 maj 1797Connecticut, USA I143821 AALT 
141 Arnold, Amy  19 sep. 1797Connecticut, USA I74799 AALT 
142 Cummins, Stephen  1798Connecticut, USA I29111 AALT 
143 Hayes, Joseph  11 dec. 1798Connecticut, USA I86864 AALT 
144 Elwell, Isaac  1799Connecticut, USA I391 AALT 
145 Boardman, Hulda  1800Connecticut, USA I36298 AALT 
146 Denison, Sarah  1800Connecticut, USA I26972 AALT 
147 Dewolf, Azubah  1800Connecticut, USA I39378 AALT 
148 Paine, Deborah  1800Connecticut, USA I39983 AALT 
149 Perkins, John  1800Connecticut, USA I23673 AALT 
150 Seymour, Ira  1800Connecticut, USA I70839 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.