Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 101 til 150 fra 494

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
101 Thomas, Constant H  1859Connecticut, USA I63480 AALT 
102 Tomlinson, Clara L.  5 okt. 1858Connecticut, USA I136311 AALT 
103 Turlon, William  15 aug. 1858Connecticut, USA I63278 AALT 
104 Moore, William J P  1858Connecticut, USA I65584 AALT 
105 Kettle, William B.  1858Connecticut, USA I96407 AALT 
106 Kettle, Allen  1857Connecticut, USA I96561 AALT 
107 Bidwell, Martin C.  1857Connecticut, USA I67125 AALT 
108 Page, Louis H  dec. 1856Connecticut, USA I83702 AALT 
109 Babcock, David Sherman  21 sep. 1856Connecticut, USA I59029 AALT 
110 Lane, Florence Carrington  5 maj 1856Connecticut, USA I62663 AALT 
111 Gould, Cora D.  1856Connecticut, USA I79263 AALT 
112 Bidwell, Nathan C.  1855Connecticut, USA I66843 AALT 
113 Bidwell, Maryett  1855Connecticut, USA I67395 AALT 
114 Thomas, Marshall K  1854Connecticut, USA I63575 AALT 
115 Norton, Henry  apr. 1853Connecticut, USA I67449 AALT 
116 Kettle, George L.  1853Connecticut, USA I96487 AALT 
117 Bidwell, Florence C.  11 jun. 1852Connecticut, USA I67226 AALT 
118 Tomlinson, Milo  maj 1852Connecticut, USA I136302 AALT 
119 Kimberly, Julia E.  27 dec. 1851Connecticut, USA I43006 AALT 
120 Babcock, Eugene  jul. 1851Connecticut, USA I84782 AALT 
121 Bidwell, Harriett  ml. 1851 og 1852Connecticut, USA I69661 AALT 
122 Williams, Ephraim  30 dec. 1850Connecticut, USA I75172 AALT 
123 Bidwell, Ella M.  7 sep. 1850Connecticut, USA I67264 AALT 
124 Stone, Anna  1850Connecticut, USA I69181 AALT 
125 Bidwell, Catherine  ml. 1850 og 1851Connecticut, USA I67067 AALT 
126 Hutchinson, Leroy  dec. 1849Connecticut, USA I46967 AALT 
127 Dickinson  1849Connecticut, USA I66959 AALT 
128 Tuttle, Julia M.  1848Connecticut, USA I63377 AALT 
129 Tuttle, Horace Whitney  7 jun. 1847Connecticut, USA I79943 AALT 
130 Palmer, Mary  17 jan. 1847Connecticut, USA I96853 AALT 
131 Pratt, Henry H.  1847Connecticut, USA I118316 AALT 
132 Kirtland, Edwin  1847Connecticut, USA I38419 AALT 
133 Hutchinson, Hiram  1847Connecticut, USA I46960 AALT 
134 Dickinson, Adelaide  1847Connecticut, USA I66892 AALT 
135 Phillips, Riley E.  jul. 1846Connecticut, USA I40356 AALT 
136 Monson, Hendrick H.  1846Connecticut, USA I62097 AALT 
137 Hutchinson, Ellen  1846Connecticut, USA I46955 AALT 
138 Bragg, Alzade Elizabeth  okt. 1845Connecticut, USA I57215 AALT 
139 Bidwell, Sarah A.  23 maj 1845Connecticut, USA I67238 AALT 
140 Cary, Julian  1845Connecticut, USA I13638 AALT 
141 Thomas, Ellen M  1844Connecticut, USA I63685 AALT 
142 Cook, Jennie  1844Connecticut, USA I63254 AALT 
143 Sarah E.  31 aug. 1843Connecticut, USA I22774 AALT 
144 Bidwell, Edward Daniel  4 jun. 1843Connecticut, USA I67251 AALT 
145 Hotchkiss, Edgar Eugene  1843Connecticut, USA I63400 AALT 
146 Gertrude F  feb. 1842Connecticut, USA I31926 AALT 
147 Tuttle, Albert P  1842Connecticut, USA I42756 AALT 
148 Stannis, Charles Edward  1842Connecticut, USA I90977 AALT 
149 Hutchinson, Adelaide  1842Connecticut, USA I46996 AALT 
150 Hamersly, Lewis Randolph  ca. 1842Connecticut, USA I96888 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Næste»



Død

Match 101 til 150 fra 276

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
101 Hubbard, Aaron  ca. 1824Connecticut, USA I94634 AALT 
102 Cary, Phineas  1824Connecticut, USA I13843 AALT 
103 Linsly, Ebenezer  8 nov. 1822Connecticut, USA I21252 AALT 
104 Haven Hemenway, Elizabeth  22 nov. 1821Connecticut, USA I136339 AALT 
105 Adams, William  21 maj 1821Connecticut, USA I11122 AALT 
106 Adams, Lois  21 maj 1821Connecticut, USA I11013 AALT 
107 Frink, Eunice  30 nov. 1820Connecticut, USA I43673 AALT 
108 Loomis, Ursalah  3 nov. 1820Connecticut, USA I11346 AALT 
109 Matson, Amy  1820Connecticut, USA I11475 AALT 
110 Barden, Sarah  28 feb. 1818Connecticut, USA I73276 AALT 
111 Elwell, Grissel  6 jun. 1816Connecticut, USA I261 AALT 
112 Knapp, Charity  jan. 1815Connecticut, USA I4928 AALT 
113 Loomis, Hannah  1815Connecticut, USA I5441 AALT 
114 Arnold, Rhodes  22 jun. 1812Connecticut, USA I74950 AALT 
115 Hosmer, Ashbel  2 apr. 1812Connecticut, USA I79257 AALT 
116 Spencer, Elizabeth  4 feb. 1812Connecticut, USA I12661 AALT 
117 Paine, Ezra  27 okt. 1811Connecticut, USA I25554 AALT 
118 Smith, Oliver  17 dec. 1810Connecticut, USA I35753 AALT 
119 Lord, Mehitabel  1810Connecticut, USA I61190 AALT 
120 Chesebrough, Prudence  29 aug. 1809Connecticut, USA I117678 AALT 
121 Kingsbury, Irena  13 feb. 1803Connecticut, USA I55730 AALT 
122 Woodward, Hannah  1801Connecticut, USA I9196 AALT 
123 Perkins, Polydore  19 nov. 1800Connecticut, USA I4461 AALT 
124 Benjamin, Johnathan  jul. 1800Connecticut, USA I12723 AALT 
125 Seymour, Ira  1800Connecticut, USA I70839 AALT 
126 Perkins, John  1800Connecticut, USA I23673 AALT 
127 Paine, Deborah  1800Connecticut, USA I39983 AALT 
128 Dewolf, Azubah  1800Connecticut, USA I39378 AALT 
129 Denison, Sarah  1800Connecticut, USA I26972 AALT 
130 Boardman, Hulda  1800Connecticut, USA I36298 AALT 
131 Elwell, Isaac  1799Connecticut, USA I391 AALT 
132 Hayes, Joseph  11 dec. 1798Connecticut, USA I86864 AALT 
133 Cummins, Stephen  1798Connecticut, USA I29111 AALT 
134 Arnold, Amy  19 sep. 1797Connecticut, USA I74799 AALT 
135 Hooker, Hannah  21 maj 1797Connecticut, USA I143821 AALT 
136 Hull, Sarah  1 feb. 1796Connecticut, USA I117807 AALT 
137 Chipman, Thomas  28 mar. 1795Connecticut, USA I124913 AALT 
138 Kneeland, Phebe  26 apr. 1793Connecticut, USA I61031 AALT 
139 Denison, Samuel  10 mar. 1792Connecticut, USA I22162 AALT 
140 Seymour, Thankful  jun. 1790Connecticut, USA I66656 AALT 
141 Drake, Job  3 apr. 1790Connecticut, USA I107397 AALT 
142 Pratt, Nn  1790Connecticut, USA I20217 AALT 
143 Pratt, Nn  1790Connecticut, USA I16058 AALT 
144 Drake, David  1790Connecticut, USA I103117 AALT 
145 Kimball, Elijah  4 nov. 1788Connecticut, USA I95177 AALT 
146 Atkins, Zilpah  26 jan. 1787Connecticut, USA I28717 AALT 
147 Gray, Anstrase  11 jun. 1785Connecticut, USA I19807 AALT 
148 Mygatt, Jonathon  1785Connecticut, USA I79476 AALT 
149 Hodge, Rhoda  10 aug. 1784Connecticut, USA I5300 AALT 
150 MacOon, Mary  1784Connecticut, USA I66300 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»



Ægteskab

Match 101 til 101 fra 101

«Forrige 1 2 3

   Familie    Ægteskab    Familie-ID   Træ 
101 Elwell / Jones  Connecticut, USA F228 AALT 

«Forrige 1 2 3



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.