Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 1 til 50 fra 494

1 2 3 4 5 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
1 Tollman, Marion C  1939Connecticut, USA I139761 AALT 
2 Tollman, Marion C  1939Connecticut, USA I69106 AALT 
3 Lane, Phelps Allyn  27 dec. 1934Connecticut, USA I63144 AALT 
4 Schuetz, Robert B  ca. 1928Connecticut, USA I758 AAP 
5 Judd, Nancy  21 okt. 1927Connecticut, USA I65786 AALT 
6 Hall, David S  1927Connecticut, USA I63180 AALT 
7 Harvey, Hope R.  1926Connecticut, USA I65660 AALT 
8 Hall, Gertrude Ellen  1926Connecticut, USA I63340 AALT 
9 Barnes, Howard  1926Connecticut, USA I67308 AALT 
10 Lanzano, Dora  17 okt. 1925Connecticut, USA I913 AAP 
11 Lanzano, Liberty  ca. 1924Connecticut, USA I912 AAP 
12 Hall, Catherine L  1924Connecticut, USA I63401 AALT 
13 Schuetz, Arnold E  18 okt. 1921Connecticut, USA I757 AAP 
14 Lanzano, Mary  ca. 1919Connecticut, USA I924 AAP 
15 Crotty, John (Jacky)  21 jul. 1918Connecticut, USA I82391 AALT 
16 Schuetz, Victoria H  5 nov. 1917Connecticut, USA I753 AAP 
17 Davis, Faith L  28 aug. 1917Connecticut, USA I99748 AALT 
18 Friend, Bernice J.  4 jan. 1915Connecticut, USA I63406 AALT 
19 Morcus, Helen  10 aug. 1914Connecticut, USA I1361 AAP 
20 Watson, Barbara Osborne  1914Connecticut, USA I65555 AALT 
21 Schuetz, Maxine H  26 jan. 1913Connecticut, USA I754 AAP 
22 Wargo, Helen E.  1912Connecticut, USA I65630 AALT 
23 Goodenough, Arthur Griswold  27 apr. 1911Connecticut, USA I65940 AALT 
24 Yale, Helen C  17 jul. 1910Connecticut, USA I74459 AALT 
25 Davis, Elizabeth  5 mar. 1910Connecticut, USA I99733 AALT 
26 Siner, Harriett Jane  8 jan. 1910Connecticut, USA I111910 AALT 
27 Brown, Allyn M  1910Connecticut, USA I65622 AALT 
28 Goodenough, Virginia A  1909Connecticut, USA I65848 AALT 
29 Barnes, Wilbur J  1909Connecticut, USA I67333 AALT 
30 Barnes, Marjorie  1909Connecticut, USA I67437 AALT 
31 Bidwell, Ruth Wagner  18 sep. 1908Connecticut, USA I67402 AALT 
32 Tuttle, Paul Whitney  14 jul. 1908Connecticut, USA I75309 AALT 
33 Brainard, Mary Louise  23 mar. 1908Connecticut, USA I63523 AALT 
34 Morcus, Bertha  ca. 1908Connecticut, USA I1363 AAP 
35 Siner, Ethel Irma  21 mar. 1906Connecticut, USA I111865 AALT 
36 Kerr, Henry Stewart  1904Connecticut, USA I67231 AALT 
37 Hills, Truman Clark  1904Connecticut, USA I67207 AALT 
38 Goodenough, Barbara A  1904Connecticut, USA I65825 AALT 
39 Bristol, Sarah Elizabeth  1904Connecticut, USA I67215 AALT 
40 Marshall, Beatrice  1903Connecticut, USA I67894 AALT 
41 Hubbell, Mabel T.  1903Connecticut, USA I63251 AALT 
42 Honor, Josephine  1903Connecticut, USA I67304 AALT 
43 Goodenough, Frieda M  1903Connecticut, USA I65408 AALT 
44 McGowan, Harriet C.  2 sep. 1900Connecticut, USA I63230 AALT 
45 Wallace, Barbara Manning  24 maj 1900Connecticut, USA I63050 AALT 
46 Goodenough, Dorothy  1900Connecticut, USA I65811 AALT 
47 Teater, William A  ca. 1899Connecticut, USA I77460 AALT 
48 Buren, Myron Van  5 jul. 1898Connecticut, USA I71903 AALT 
49 Hall, Mabel H  mar. 1898Connecticut, USA I63308 AALT 
50 Fowler, Helen P  maj 1896Connecticut, USA I62766 AALT 

1 2 3 4 5 ... 10» Næste»



Dåb

Match 1 til 10 fra 10

   Efternavn, Fornavn    Dåb    Person-ID   Træ 
1 Hart, Azuba  16 sep. 1792Connecticut, USA I71428 AALT 
2 Lay, Abigail  28 mar. 1773Connecticut, USA I91651 AALT 
3 Patchen, Elizabeth  10 jun. 1744Connecticut, USA I55425 AALT 
4 Coit, Sarah  1726Connecticut, USA I2843 AAP 
5 Owen, Keziah  1724Connecticut, USA I26899 AALT 
6 Peck, Ruth  3 maj 1696Connecticut, USA I46391 AALT 
7 Loomis, John Deacon  27 aug. 1688Connecticut, USA I60880 AALT 
8 Filley, Deborah  24 nov. 1661Connecticut, USA I54272 AALT 
9 Edwards, Jonathan  Connecticut, USA I140266 AALT 
10 Babcock, William Robinson  Connecticut, USA I74972 AALT 

Død

Match 1 til 50 fra 276

1 2 3 4 5 ... Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
1 Pattee, Susan E.  28 jun. 1998Connecticut, USA I68561 AALT 
2 Brainard, Mary Louise  28 sep. 1989Connecticut, USA I63523 AALT 
3 Millington, Catherine  1978Connecticut, USA I134445 AALT 
4 Hart, Lena May  1963Connecticut, USA I67235 AALT 
5 Goodenough, Giles Frederick  jan. 1960Connecticut, USA I65816 AALT 
6 Goodenough, Priscilla Pauline  25 nov. 1959Connecticut, USA I65847 AALT 
7 Schuetz, Henry August Jr  10 dec. 1955Connecticut, USA I759 AAP 
8 Bitgood, Frederick Ellsworth  21 jan. 1938Connecticut, USA I96107 AALT 
9 North, Sarah Maria  1935Connecticut, USA I67202 AALT 
10 Hemingway, Willis J.  4 nov. 1931Connecticut, USA I14814 AALT 
11 Marvin, Martha  21 jun. 1930Connecticut, USA I126248 AALT 
12 Judd, Nancy  27 okt. 1927Connecticut, USA I65786 AALT 
13 Tanner, Luther S.  1927Connecticut, USA I80674 AALT 
14 Bidwell, Grove Sherman  1926Connecticut, USA I67343 AALT 
15 Bidwell, George Edmund  1922Connecticut, USA I69110 AALT 
16 Manning, Sarah Rose  21 feb. 1918Connecticut, USA I62695 AALT 
17 Seaman, Jane E.  1918Connecticut, USA I51274 AALT 
18 Elwell, Angeline  9 maj 1914Connecticut, USA I10700 AALT 
19 Moore, Col. Samuel A.  11 maj 1912Connecticut, USA I65982 AALT 
20 Tanner, William Warren  23 aug. 1911Connecticut, USA I80570 AALT 
21 Hogarty, Mary Emily  17 aug. 1910Connecticut, USA I96219 AALT 
22 Pember, Jane King  9 dec. 1909Connecticut, USA I65860 AALT 
23 Bidwell, Frederick Albert  1907Connecticut, USA I67274 AALT 
24 Bixby, Joseph Edward  12 okt. 1905Connecticut, USA I38111 AALT 
25 Hemingway, Jacob Willis  20 maj 1905Connecticut, USA I28289 AALT 
26 Hemingway, Esther B  3 jun. 1903Connecticut, USA I7307 AALT 
27 Andrews, Harriet Gordon  24 okt. 1902Connecticut, USA I96427 AALT 
28 Kenyon, Phebe Caroline  2 nov. 1896Connecticut, USA I82899 AALT 
29 Miner, Joseph Latham  7 sep. 1894Connecticut, USA I96002 AALT 
30 Hester, Terresa J  1 nov. 1893Connecticut, USA I48338 AALT 
31 Hoadley, Mary Ann  31 mar. 1893Connecticut, USA I136303 AALT 
32 Stanton, Benjamin Franklin  13 maj 1892Connecticut, USA I75365 AALT 
33 Peck, Martha "Patty"  10 aug. 1891Connecticut, USA I37624 AALT 
34 Bitgood, Joseph Sheffield  1889Connecticut, USA I96244 AALT 
35 Peck, Samuel  26 apr. 1888Connecticut, USA I37647 AALT 
36 Lee, Laura L  24 aug. 1887Connecticut, USA I34007 AALT 
37 Hall, Abel L  1884Connecticut, USA I72389 AALT 
38 Watson, Edmund  11 sep. 1883Connecticut, USA I62193 AALT 
39 Brewster, Eugenia Juliet  26 jul. 1883Connecticut, USA I17087 AALT 
40 Marsh, Maria  8 feb. 1881Connecticut, USA I65703 AALT 
41 Franklin, Richard L.  7 sep. 1880Connecticut, USA I81271 AALT 
42 Hayes, Asa  23 feb. 1879Connecticut, USA I87040 AALT 
43 Crary, Evelina  1879Connecticut, USA I81017 AALT 
44 Peck, Pamelia  1878Connecticut, USA I39196 AALT 
45 Stoddard, Mary Ann  3 apr. 1877Connecticut, USA I41406 AALT 
46 Bosworth, Luna  15 mar. 1876Connecticut, USA I42533 AALT 
47 Balch, Thomas  1 jul. 1871Connecticut, USA I62802 AALT 
48 Smith, Sally Denison  14 mar. 1871Connecticut, USA I35812 AALT 
49 Hemingway, Samuel S  15 feb. 1871Connecticut, USA I7254 AALT 
50 Crawford, Elizabeth  1869Connecticut, USA I91061 AALT 

1 2 3 4 5 ... Næste»



Begravelse

Match 1 til 50 fra 84

1 2 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Begravelse    Person-ID   Træ 
1 Morgan, George W  1865Connecticut, USA I135810 AALT 
2 Adams, Lois  maj 1821Connecticut, USA I11013 AALT 
3 Dodge, Stephen  1809Connecticut, USA I60782 AALT 
4 Spencer, Roswell  1806Connecticut, USA I27012 AALT 
5 Bingham, Daniel  1 feb. 1805Connecticut, USA I29099 AALT 
6 Griswold, Josiah  1800Connecticut, USA I9783 AALT 
7 Loomis, Hannah  okt. 1778Connecticut, USA I5247 AALT 
8 Brewster, Anne  jan. 1776Connecticut, USA I136318 AALT 
9 Brewster, Anne  jan. 1776Connecticut, USA I125176 AALT 
10 Pease, John  jun. 1761Connecticut, USA I86584 AALT 
11 Pease, John  jun. 1761Connecticut, USA I86334 AALT 
12 Tarbox, Sarah  aug. 1754Connecticut, USA I29453 AALT 
13 Parke, Hezekiah  feb. 1752Connecticut, USA I24977 AALT 
14 Brewster, Elisha  1746Connecticut, USA I12709 AALT 
15 Griswold, Jerusha  mar. 1745Connecticut, USA I124958 AALT 
16 Bixby, Benjamin  dec. 1744Connecticut, USA I29292 AALT 
17 Clark, Isaac  1744Connecticut, USA I1856 AALT 
18 Phelps, Captain Samuel  okt. 1741Connecticut, USA I103455 AALT 
19 Brewster, William  nov. 1726Connecticut, USA I12774 AALT 
20 Noyes, James Jr.  1718Connecticut, USA I35330 AALT 
21 Hanchett, Deliverance Hannah  nov. 1711Connecticut, USA I46003 AALT 
22 Cooper, Sarah  1711Connecticut, USA I62158 AALT 
23 De Wolf, Simon  1704Connecticut, USA I13173 AALT 
24 Belden, John  jun. 1677Connecticut, USA I62606 AALT 
25 Woodruff, Philo  Connecticut, USA I35251 AALT 
26 Whittemore, Alvan Fosdick  Connecticut, USA I94556 AALT 
27 Whitmore, Elizabeth  Connecticut, USA I94664 AALT 
28 Tudor, Mary  Connecticut, USA I13422 AALT 
29 Timmerman, William Orton  Connecticut, USA I66058 AALT 
30 Tanner, Susan Mercelia  Connecticut, USA I13600 AALT 
31 Tanner, Joseph  Connecticut, USA I27287 AALT 
32 Storrs, Hannah  Connecticut, USA I52043 AALT 
33 Spencer, Elizabeth  Connecticut, USA I126813 AALT 
34 Simmons, Abigail  Connecticut, USA I10633 AALT 
35 Shepard, Isaac  Connecticut, USA I117719 AALT 
36 Sanford, Susan Alice  Connecticut, USA I64065 AALT 
37 Sanford, Robert  Connecticut, USA I60449 AALT 
38 Preston, Esther  Connecticut, USA I87032 AALT 
39 Pratt, Hepsibah  Connecticut, USA I94594 AALT 
40 Pratt, Elisabeth  Connecticut, USA I94584 AALT 
41 Parmalee, Mildred Ives  Connecticut, USA I62899 AALT 
42 Parmalee, Charles Ives  Connecticut, USA I62578 AALT 
43 North, Hannah  Connecticut, USA I29702 AALT 
44 Morgan, Sarah  Connecticut, USA I134337 AALT 
45 Morgan, John Jr.  Connecticut, USA I136328 AALT 
46 Morgan, John Jr.  Connecticut, USA I27224 AALT 
47 Morgan, Daniel  Connecticut, USA I135785 AALT 
48 Metcalfe, Simeon  Connecticut, USA I26966 AALT 
49 Meach, Moses  Connecticut, USA I27221 AALT 
50 Marvin, Martha  Connecticut, USA I126248 AALT 

1 2 Næste»



Arrival

Match 1 til 4 fra 4

   Efternavn, Fornavn    Arrival    Person-ID   Træ 
1 Blakeslee, Samuel  1650Connecticut, USA I22909 AALT 
2 Champion, Henry  1647Connecticut, USA I54477 AALT 
3 Andrews, Francis  1639Connecticut, USA I2819 AAP 
4 Churchill, Josiah  1635Connecticut, USA I21766 AALT 

Beskæftigelse

Match 1 til 1 fra 1

   Efternavn, Fornavn    Beskæftigelse    Person-ID   Træ 
1 Christophers, Captain Richard  ml. 1701 og 1706Connecticut, USA I2840 AAP 

Bopæl

Match 1 til 17 fra 17

   Efternavn, Fornavn    Bopæl    Person-ID   Træ 
1 Woodruff, Newton  1870Connecticut, USA I35151 AALT 
2 Tanner, George Allen  1870Connecticut, USA I80688 AALT 
3 Smith, Maria  1870Connecticut, USA I94686 AALT 
4 Denison, Ann Elizabeth  1870Connecticut, USA I33438 AALT 
5 Babcock, Stephen Tyng  1870Connecticut, USA I55367 AALT 
6 Babcock, Mary Denison  1870Connecticut, USA I75187 AALT 
7 Babcock, Lucy Bell  1870Connecticut, USA I59181 AALT 
8 Babcock, Lucy Bell  1870Connecticut, USA I33346 AALT 
9 Henshaw, Benjamin  1818Connecticut, USA I112516 AALT 
10 Ford, Benoni  1778Connecticut, USA I107565 AALT 
11 Gaylord, William  ml. 1650 og 1800Connecticut, USA I19443 AALT 
12 Tudor, Owen  Connecticut, USA I22654 AALT 
13 Teneyke, Elizabeth J.  Connecticut, USA I107826 AALT 
14 Pardee, David Hunter  Connecticut, USA I142182 AALT 
15 Pardee, Daniel Johns  Connecticut, USA I142187 AALT 
16 Henshaw, William  Connecticut, USA I113525 AALT 
17 Henshaw, William  Connecticut, USA I113525 AALT 

Dåb

Match 1 til 1 fra 1

   Efternavn, Fornavn    Dåb    Person-ID   Træ 
1 Peck, Ruth  3 maj 1696Connecticut, USA I46391 AALT 

Død

Match 1 til 2 fra 2

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
1 Gibbs, Lydia  1765Connecticut, USA I87010 AALT 
2 Dyer, Mary  20 dec. 1740Connecticut, USA I49623 AALT 

Fødsel

Match 1 til 7 fra 7

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
1 Williams, Ephraim  1875Connecticut, USA I75017 AALT 
2 Hart, Ezra  17 maj 1801Connecticut, USA I125958 AALT 
3 Drake, Abraham  1784Connecticut, USA I52326 AALT 
4 Amidon, Eunice  1784Connecticut, USA I127205 AALT 
5 Amidon, Eunice  1784Connecticut, USA I127205 AALT 
6 Wightman, Uriah  1775Connecticut, USA I46621 AALT 
7 Stebbins, Isabella  1687Connecticut, USA I62205 AALT 

Indvandring

Match 1 til 2 fra 2

   Efternavn, Fornavn    Indvandring    Person-ID   Træ 
1 Sherwood, Thomas  apr. 1634Connecticut, USA I57631 AALT 
2 Pond, Samuel I  1630Connecticut, USA I139150 AALT 

Marriage Record

Match 1 til 1 fra 1

   Efternavn, Fornavn    Marriage Record    Person-ID   Træ 
1 Barnes, Thomas 5th  1690Connecticut, USA I2822 AAP 

Obituary

Match 1 til 3 fra 3

   Efternavn, Fornavn    Obituary    Person-ID   Træ 
1 Lanzano, Dora  27 feb. 2007Connecticut, USA I913 AAP 
2 Sedgwick, Ruth Joy  23 jan. 2004Connecticut, USA I36254 AALT 
3 Bianco, Maria ( Mary )  16 maj 1995Connecticut, USA I3379 AAP 

_MILT

Match 1 til 9 fra 9

   Efternavn, Fornavn    _MILT    Person-ID   Træ 
1 Pease, David  6 aug. 1782Connecticut, USA I86583 AALT 
2 Pease, David  jun. 1782Connecticut, USA I86583 AALT 
3 Henshaw, William  14 dec. 1779Connecticut, USA I113525 AALT 
4 Pardee, Jonathan  19 okt. 1777Connecticut, USA I142176 AALT 
5 Rodgers, Abijah  1 aug. 1777Connecticut, USA I87051 AALT 
6 Prichard, Benjamin III  26 apr. 1777Connecticut, USA I100097 AALT 
7 Pratt, Benjamin Jr.  ml. 1755 og 1762Connecticut, USA I91742 AALT 
8 Sherwood, Thomas  Connecticut, USA I57631 AALT 
9 Herrick, Amos  Connecticut, USA I98758 AALT 

Ægteskab

Match 1 til 50 fra 101

1 2 3 Næste»

   Familie    Ægteskab    Familie-ID   Træ 
1 Judd / Hudson  1931Connecticut, USA F13033 AALT 
2 Story / Brainard  14 apr. 1928Connecticut, USA F12287 AALT 
3 Judd / Brown  1926Connecticut, USA F13200 AALT 
4 Judd / Marvin  1925Connecticut, USA F13032 AALT 
5 Friend / Tuttle  1913Connecticut, USA F12251 AALT 
6 Kelsey / Gladwin  1908Connecticut, USA F14540 AALT 
7 Yale / Andrews  31 jul. 1907Connecticut, USA F12249 AALT 
8 Bristol / Humphrey  30 mar. 1904Connecticut, USA F13555 AALT 
9 Brainerd / Pattee  30 aug. 1898Connecticut, USA F12239 AALT 
10 Hubbell / Tuttle  1891Connecticut, USA F12217 AALT 
11 Gillette / Williams  1 jun. 1886Connecticut, USA F26930 AALT 
12 Bidwell / Burr  10 maj 1882Connecticut, USA F13578 AALT 
13 Bishop / Peck  27 jul. 1870Connecticut, USA F12009 AALT 
14 Bidwell / Stone  1870Connecticut, USA F14546 AALT 
15 Monson / Todd  11 nov. 1868Connecticut, USA F11811 AALT 
16 Yale / Wilcox Yale  18 dec. 1867Connecticut, USA F12115 AALT 
17 Moore / Pember  1867Connecticut, USA F13147 AALT 
18 Terry / Sanford  2 sep. 1865Connecticut, USA F12485 AALT 
19 Austin / Yale  1865Connecticut, USA F12222 AALT 
20 Hopkins / Hotchkiss  9 jun. 1861Connecticut, USA F12154 AALT 
21 Tanner / Campbell  17 okt. 1857Connecticut, USA F4733 AALT 
22 Lane / Carrington  jul. 1855Connecticut, USA F12101 AALT 
23 Judd / Welles  25 apr. 1855Connecticut, USA F13054 AALT 
24 Bitgood / Pratt  12 jan. 1852Connecticut, USA F19491 AALT 
25 Lyon / Page  6 maj 1848Connecticut, USA F30162 AALT 
26 Tuttle / Beecher  1847Connecticut, USA F12182 AALT 
27 Brewster / Ketchem  ca. 1847Connecticut, USA F30220 AALT 
28 Hitchcock / Sedgwick  21 aug. 1846Connecticut, USA F12962 AALT 
29 Kirtland / Stannard  1846Connecticut, USA F12289 AALT 
30 Seymour / Hoadley  17 sep. 1836Connecticut, USA F30565 AALT 
31 Tuttle / Beecher  1834Connecticut, USA F17020 AALT 
32 Kirtland / Benham  4 jul. 1829Connecticut, USA F12065 AALT 
33 Wadsworth / Isham  22 okt. 1825Connecticut, USA F753 AAP 
34 Sedgwick / Ensign  17 okt. 1825Connecticut, USA F11915 AALT 
35 Bidwell / Graham  1824Connecticut, USA F13552 AALT 
36 Huntington / Bibbens  23 feb. 1823Connecticut, USA F4895 AALT 
37 Yale / Kirtland  23 jul. 1822Connecticut, USA F14260 AALT 
38 Sedgwick / Webster Mix  jun. 1820Connecticut, USA F12718 AALT 
39 Hemingway / Hinman  1820Connecticut, USA F2995 AALT 
40 Sedgwick / Merriam  8 maj 1819Connecticut, USA F11868 AALT 
41 Kirtland / Carrington  22 feb. 1819Connecticut, USA F12237 AALT 
42 Shepard / Angell  1817Connecticut, USA F6003 AALT 
43 Root / Hemingway  1816Connecticut, USA F2255 AALT 
44 Bingham / Waldo  21 sep. 1814Connecticut, USA F5765 AALT 
45 Babcock / Fuller  1814Connecticut, USA F7364 AALT 
46 Carrington / Kirtland  22 sep. 1812Connecticut, USA F11986 AALT 
47 Cutler / Stebbins  1810Connecticut, USA F3587 AALT 
48 Bidwell / Hotchkiss  1810Connecticut, USA F13339 AALT 
49 Humphrey / Bidwell  1808Connecticut, USA F14186 AALT 
50 Hemingway / Smith  1807Connecticut, USA F2996 AALT 

1 2 3 Næste»



Viet

Match 1 til 6 fra 6

   Familie    Viet    Familie-ID   Træ 
1 Babcock / Denison  13 okt. 1832Connecticut, USA F7089 AALT 
2 Wadsworth / Isham  22 okt. 1828Connecticut, USA F753 AAP 
3 Ogden / Baldwin  1745Connecticut, USA F16216 AALT 
4 Loomis / Holbrook  27 sep. 1743Connecticut, USA F8985 AALT 
5 Hooker / Webster  ca. 1735Connecticut, USA F16278 AALT 
6 Bidwell / Wilcox  1647Connecticut, USA F11517 AALT 

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.