Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 351 til 400 fra 469

«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
351 Rudd, Betsy Betty  28 jun. 1765Connecticut, USA I10494 AALT 
352 Rudd, Elisha  1732Connecticut, USA I25919 AALT 
353 Rude, Mehitable  1772Connecticut, USA I10109 AALT 
354 Russell, Thomas  1687Connecticut, USA I244 AALT 
355 Seaman, Sellinda  1810Connecticut, USA I46873 AALT 
356 Sedgwick, Jane  1836Connecticut, USA I65586 AALT 
357 Sedgwick, Sarah  25 mar. 1739Connecticut, USA I62297 AALT 
358 Sedgwick, Theodore  29 mar. 1837Connecticut, USA I41583 AALT 
359 Seward, Elizabeth  7 dec. 1734Connecticut, USA I24763 AALT 
360 Seymour  1819Connecticut, USA I65635 AALT 
361 Seymour, Ann Maria  10 jul. 1815Connecticut, USA I65580 AALT 
362 Seymour, George  1811Connecticut, USA I136299 AALT 
363 Seymour, Roswell  1821Connecticut, USA I65796 AALT 
364 Seymour, Wellington  1816Connecticut, USA I65371 AALT 
365 Shaw, Lydia  1753Connecticut, USA I131239 AALT 
366 Shaw, Rhoda  7 jan. 1790Connecticut, USA I66753 AALT 
367 Shelden, Adeline  1817Connecticut, USA I43799 AALT 
368 Shepard, Caleb A.  1818Connecticut, USA I14126 AALT 
369 Siner, Ethel Irma  21 mar. 1906Connecticut, USA I111865 AALT 
370 Siner, Harriett Jane  8 jan. 1910Connecticut, USA I111910 AALT 
371 Slate Mr.  1720Connecticut, USA I27110 AALT 
372 Smith, Deborah  1711Connecticut, USA I61683 AALT 
373 Smith, Lucretia  1786Connecticut, USA I23757 AALT 
374 Smith, Nathaniel Roswell  24 nov. 1778Connecticut, USA I61018 AALT 
375 Smith, Sally Denison  28 aug. 1779Connecticut, USA I35812 AALT 
376 Spencer, Catherine  1778Connecticut, USA I11394 AALT 
377 Spencer, Child  1793Connecticut, USA I15628 AALT 
378 Spencer, Eldad  1730Connecticut, USA I12930 AALT 
379 Spencer, Hannah  1784Connecticut, USA I12747 AALT 
380 Spencer, Jane  1735Connecticut, USA I21119 AALT 
381 Spencer, Martha  1 sep. 1745Connecticut, USA I27087 AALT 
382 Spencer, Mary  11 okt. 1780Connecticut, USA I12824 AALT 
383 Stacy, Susan Ann  1657Connecticut, USA I18236 AALT 
384 Stannard, Mary  ca. 1755Connecticut, USA I92541 AALT 
385 Stannis, Charles Edward  1842Connecticut, USA I90977 AALT 
386 Stannis, Frank A.  23 maj 1869Connecticut, USA I115063 AALT 
387 Sterling, Sally  1715Connecticut, USA I13480 AALT 
388 Stevens, Moses  Connecticut, USA I120 AALT 
389 Stiles, Jonathan  11 aug. 1780Connecticut, USA I9422 AALT 
390 Stiles, Lucy  1752Connecticut, USA I96139 AALT 
391 Stiles, Patty  1782Connecticut, USA I9454 AALT 
392 Stone, Anna  1850Connecticut, USA I69181 AALT 
393 Strong, Jonathan  1777Connecticut, USA I16446 AALT 
394 Strong, Jonathan Q  1768Connecticut, USA I12878 AALT 
395 Strong, Mary  1779Connecticut, USA I13029 AALT 
396 Summers, Martha  1684Connecticut, USA I55377 AALT 
397 Tallman, Stephen Sr  12 maj 1768Connecticut, USA I139120 AALT 
398 Tanner, Edmund A.  1869Connecticut, USA I16671 AALT 
399 Tanner, John E.  1864Connecticut, USA I29545 AALT 
400 Tanner, Margaret E.  jan. 1884Connecticut, USA I17295 AALT 

«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Næste»



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.