Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 51 til 100 fra 469

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
51 Armstrong, John  1718Connecticut, USA I9491 AALT 
52 Slate Mr.  1720Connecticut, USA I27110 AALT 
53 Phelps, Abigail  1721Connecticut, USA I127209 AALT 
54 Drake, Elizabeth  4 maj 1721Connecticut, USA I58435 AALT 
55 Phelps, Alexander  1723Connecticut, USA I126942 AALT 
56 Brewster, Truelove  16 maj 1725Connecticut, USA I135738 AALT 
57 Cadger, Mrs.  1726Connecticut, USA I100520 AALT 
58 Fillmore, John III  1726Connecticut, USA I56453 AALT 
59 Coats, Katherine  1727Connecticut, USA I2190 AALT 
60 Phelps, Mehitable  1727Connecticut, USA I126947 AALT 
61 Drake, Marcus  13 jan. 1727Connecticut, USA I55812 AALT 
62 Paddock, Bethia  22 jan. 1729Connecticut, USA I26751 AALT 
63 Brewster, Judah  27 feb. 1729Connecticut, USA I13014 AALT 
64 Blakeslee, Joseph  1730Connecticut, USA I1698 AALT 
65 Morgan, Richard Jr.  ca. 1730Connecticut, USA I44819 AALT 
66 Spencer, Eldad  1730Connecticut, USA I12930 AALT 
67 Trowbridge, Abigail  1731Connecticut, USA I8106 AALT 
68 Jones, Ebenezer  1732Connecticut, USA I8867 AALT 
69 Rudd, Elisha  1732Connecticut, USA I25919 AALT 
70 Richards, Moses  6 mar. 1733Connecticut, USA I27841 AALT 
71 Goodwin, Isaac  17 apr. 1733Connecticut, USA I127457 AALT 
72 Angel, Jemima  21 maj 1733Connecticut, USA I124315 AALT 
73 Tanner, Ruth  1734Connecticut, USA I5212 AALT 
74 Seward, Elizabeth  7 dec. 1734Connecticut, USA I24763 AALT 
75 Spencer, Jane  1735Connecticut, USA I21119 AALT 
76 Bidwell, Ruhama  1737Connecticut, USA I59571 AALT 
77 Sedgwick, Sarah  25 mar. 1739Connecticut, USA I62297 AALT 
78 Amy  1740Connecticut, USA I27538 AALT 
79 Laurence, Mary Townley  1741Connecticut, USA I139772 AALT 
80 Peat, Abigail  ca. 1744Connecticut, USA I25927 AALT 
81 Butt, Deliah  1745Connecticut, USA I25134 AALT 
82 Trowbridge, Stephan  1745Connecticut, USA I8253 AALT 
83 Spencer, Martha  1 sep. 1745Connecticut, USA I27087 AALT 
84 Ford, Daniel  1746Connecticut, USA I110002 AALT 
85 Peck, Ruth  1746Connecticut, USA I57720 AALT 
86 Brockett, Isaac  1747Connecticut, USA I62856 AALT 
87 Cable, Abigail  1748Connecticut, USA I13616 AALT 
88 Baker, Joseph  17 dec. 1748Connecticut, USA I4254 AALT 
89 Gates, Abel  ca. 1749Connecticut, USA I49191 AALT 
90 Babcock, Jesse  29 mar. 1749Connecticut, USA I33810 AALT 
91 Gardiner, William  8 sep. 1749Connecticut, USA I1005 AALT 
92 Hopkins, Sarah  ca. 1750Connecticut, USA I30943 AALT 
93 Hodges, Rebecca  1751Connecticut, USA I71 AALT 
94 Elwell, Deborah  1752Connecticut, USA I307 AALT 
95 Lathrop, Sarah  1752Connecticut, USA I29595 AALT 
96 Stiles, Lucy  1752Connecticut, USA I96139 AALT 
97 Shaw, Lydia  1753Connecticut, USA I131239 AALT 
98 Pratt, Nathan  7 nov. 1753Connecticut, USA I94694 AALT 
99 Elwell, John  1755Connecticut, USA I437 AALT 
100 Gates, Thomas  ca. 1755Connecticut, USA I49194 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Næste»



Død

Match 51 til 100 fra 273

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
51 Mansfield, Samuel  12 dec. 1705Connecticut, USA I137617 AALT 
52 Prout, Margaret  1720Connecticut, USA I137646 AALT 
53 Peck, Ruth  29 mar. 1728Connecticut, USA I46391 AALT 
54 Johnson, Ruth  11 dec. 1728Connecticut, USA I19381 AALT 
55 Couch, Mary  1729Connecticut, USA I112266 AALT 
56 Dodd, Edward  1729Connecticut, USA I26983 AALT 
57 Dunbar, Joseph  1730Connecticut, USA I74052 AALT 
58 Rollo, William  30 maj 1732Connecticut, USA I104381 AALT 
59 Knowles, Mercy  5 jun. 1732Connecticut, USA I35303 AALT 
60 Durkee, Jeremiah  30 jan. 1734Connecticut, USA I43796 AALT 
61 Alling, Ebenezer  18 sep. 1734Connecticut, USA I140296 AALT 
62 Buell, Sarah  4 okt. 1734Connecticut, USA I48658 AALT 
63 Talmadge, Kezia  1737Connecticut, USA I57875 AALT 
64 Griswold, John  13 jun. 1738Connecticut, USA I50483 AALT 
65 Ward, Ambrose  14 nov. 1739Connecticut, USA I42481 AALT 
66 Millington, John  8 jul. 1740Connecticut, USA I72972 AALT 
67 Pratt, Nathaniel  1744Connecticut, USA I165 AALT 
68 Porter, Experience  28 okt. 1744Connecticut, USA I57556 AALT 
69 Knight, Rachel  24 nov. 1744Connecticut, USA I72917 AALT 
70 Holbrook, Mary  3 apr. 1745Connecticut, USA I93936 AALT 
71 Bartlett Jr., Samuel Jr.  19 nov. 1746Connecticut, USA I113631 AALT 
72 Hawes, Sarah  1747Connecticut, USA I29499 AALT 
73 Bidwell, Moses  3 aug. 1748Connecticut, USA I59669 AALT 
74 Smith, Richard  1749Connecticut, USA I102279 AALT 
75 Barrett, Susannah  4 jan. 1749Connecticut, USA I71285 AALT 
76 Barrett, Phebe  13 jan. 1749Connecticut, USA I72435 AALT 
77 Williams, Hannah  eft. 4 okt. 1749Connecticut, USA I94608 AALT 
78 Phelps, Mehitable  1752Connecticut, USA I126947 AALT 
79 Rudd, Nathaniel  12 jul. 1752Connecticut, USA I25438 AALT 
80 Keeler, Sarah  1756Connecticut, USA I47279 AALT 
81 Belden, Daniel  24 dec. 1759Connecticut, USA I26556 AALT 
82 Ellsworth, John  1760Connecticut, USA I108144 AALT 
83 Lord, Mehitabel  1760Connecticut, USA I60927 AALT 
84 Mygatt, Webster  5 maj 1760Connecticut, USA I79506 AALT 
85 Hale, Samuel  20 sep. 1760Connecticut, USA I4662 AALT 
86 Chapman, Benjamin  15 dec. 1760Connecticut, USA I357 AALT 
87 Atkins, Mary  eft. 1760Connecticut, USA I100367 AALT 
88 Howe, Sarah  1761Connecticut, USA I43910 AALT 
89 Sabin, Hezekiah  ca. 1762Connecticut, USA I37761 AALT 
90 Avery, James  1763Connecticut, USA I75631 AALT 
91 Bridwell, John  1763Connecticut, USA I27180 AALT 
92 Leffingwell, Mary  9 jul. 1764Connecticut, USA I114928 AALT 
93 Knowles, Cornelius  28 dec. 1764Connecticut, USA I35278 AALT 
94 Stevens, Esther  1765Connecticut, USA I191 AALT 
95 Stevens, Mabel  1765Connecticut, USA I363 AALT 
96 Stevens, Mary  1765Connecticut, USA I110 AALT 
97 Greene, Jeremiah  1766Connecticut, USA I5187 AALT 
98 Brown, Katurah  20 mar. 1766Connecticut, USA I27144 AALT 
99 Morgan, Theophilus Sr.  22 nov. 1766Connecticut, USA I136329 AALT 
100 Pratt, David Jr.  eft. 1766Connecticut, USA I38999 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»



Begravelse

Match 51 til 83 fra 83

«Forrige 1 2

   Efternavn, Fornavn    Begravelse    Person-ID   Træ 
51 Spencer, Elizabeth  Connecticut, USA I126813 AALT 
52 Storrs, Hannah  Connecticut, USA I52043 AALT 
53 Tanner, Joseph  Connecticut, USA I27287 AALT 
54 Tanner, Susan Mercelia  Connecticut, USA I13600 AALT 
55 Timmerman, William Orton  Connecticut, USA I66058 AALT 
56 Tudor, Mary  Connecticut, USA I13422 AALT 
57 Whitmore, Elizabeth  Connecticut, USA I94664 AALT 
58 Whittemore, Alvan Fosdick  Connecticut, USA I94556 AALT 
59 Woodruff, Philo  Connecticut, USA I35251 AALT 
60 Belden, John  jun. 1677Connecticut, USA I62606 AALT 
61 De Wolf, Simon  1704Connecticut, USA I13173 AALT 
62 Cooper, Sarah  1711Connecticut, USA I62158 AALT 
63 Hanchett, Deliverance Hannah  nov. 1711Connecticut, USA I46003 AALT 
64 Noyes, James Jr.  1718Connecticut, USA I35330 AALT 
65 Brewster, William  nov. 1726Connecticut, USA I12774 AALT 
66 Phelps, Captain Samuel  okt. 1741Connecticut, USA I103455 AALT 
67 Clark, Isaac  1744Connecticut, USA I1856 AALT 
68 Bixby, Benjamin  dec. 1744Connecticut, USA I29292 AALT 
69 Griswold, Jerusha  mar. 1745Connecticut, USA I124958 AALT 
70 Brewster, Elisha  1746Connecticut, USA I12709 AALT 
71 Parke, Hezekiah  feb. 1752Connecticut, USA I24977 AALT 
72 Tarbox, Sarah  aug. 1754Connecticut, USA I29453 AALT 
73 Pease, John  jun. 1761Connecticut, USA I86584 AALT 
74 Pease, John  jun. 1761Connecticut, USA I86334 AALT 
75 Brewster, Anne  jan. 1776Connecticut, USA I136318 AALT 
76 Brewster, Anne  jan. 1776Connecticut, USA I125176 AALT 
77 Loomis, Hannah  okt. 1778Connecticut, USA I5247 AALT 
78 Griswold, Josiah  1800Connecticut, USA I9783 AALT 
79 Bingham, Daniel  1 feb. 1805Connecticut, USA I29099 AALT 
80 Spencer, Roswell  1806Connecticut, USA I27012 AALT 
81 Dodge, Stephen  1809Connecticut, USA I60782 AALT 
82 Adams, Lois  maj 1821Connecticut, USA I11013 AALT 
83 Morgan, George W  1865Connecticut, USA I135810 AALT 

«Forrige 1 2



Ægteskab

Match 51 til 99 fra 99

«Forrige 1 2

   Familie    Ægteskab    Familie-ID   Træ 
51 Hemingway / Smith  1807Connecticut, USA F2996 AALT 
52 Humphrey / Bidwell  1808Connecticut, USA F14186 AALT 
53 Bidwell / Hotchkiss  1810Connecticut, USA F13339 AALT 
54 Cutler / Stebbins  1810Connecticut, USA F3587 AALT 
55 Carrington / Kirtland  22 sep. 1812Connecticut, USA F11986 AALT 
56 Babcock / Fuller  1814Connecticut, USA F7364 AALT 
57 Bingham / Waldo  21 sep. 1814Connecticut, USA F5765 AALT 
58 Root / Hemingway  1816Connecticut, USA F2255 AALT 
59 Shepard / Angell  1817Connecticut, USA F6003 AALT 
60 Kirtland / Carrington  22 feb. 1819Connecticut, USA F12237 AALT 
61 Sedgwick / Merriam  8 maj 1819Connecticut, USA F11868 AALT 
62 Hemingway / Hinman  1820Connecticut, USA F2995 AALT 
63 Sedgwick / Webster Mix  jun. 1820Connecticut, USA F12718 AALT 
64 Yale / Kirtland  23 jul. 1822Connecticut, USA F14260 AALT 
65 Huntington / Bibbens  23 feb. 1823Connecticut, USA F4895 AALT 
66 Bidwell / Graham  1824Connecticut, USA F13552 AALT 
67 Sedgwick / Ensign  17 okt. 1825Connecticut, USA F11915 AALT 
68 Kirtland / Benham  4 jul. 1829Connecticut, USA F12065 AALT 
69 Tuttle / Beecher  1834Connecticut, USA F17020 AALT 
70 Seymour / Hoadley  17 sep. 1836Connecticut, USA F30565 AALT 
71 Kirtland / Stannard  1846Connecticut, USA F12289 AALT 
72 Hitchcock / Sedgwick  21 aug. 1846Connecticut, USA F12962 AALT 
73 Brewster / Ketchem  ca. 1847Connecticut, USA F30220 AALT 
74 Tuttle / Beecher  1847Connecticut, USA F12182 AALT 
75 Lyon / Page  6 maj 1848Connecticut, USA F30162 AALT 
76 Bitgood / Pratt  12 jan. 1852Connecticut, USA F19491 AALT 
77 Judd / Welles  25 apr. 1855Connecticut, USA F13054 AALT 
78 Lane / Carrington  jul. 1855Connecticut, USA F12101 AALT 
79 Tanner / Campbell  17 okt. 1857Connecticut, USA F4733 AALT 
80 Hopkins / Hotchkiss  9 jun. 1861Connecticut, USA F12154 AALT 
81 Austin / Yale  1865Connecticut, USA F12222 AALT 
82 Terry / Sanford  2 sep. 1865Connecticut, USA F12485 AALT 
83 Moore / Pember  1867Connecticut, USA F13147 AALT 
84 Yale / Wilcox Yale  18 dec. 1867Connecticut, USA F12115 AALT 
85 Monson / Todd  11 nov. 1868Connecticut, USA F11811 AALT 
86 Bidwell / Stone  1870Connecticut, USA F14546 AALT 
87 Bishop / Peck  27 jul. 1870Connecticut, USA F12009 AALT 
88 Bidwell / Burr  10 maj 1882Connecticut, USA F13578 AALT 
89 Gillette / Williams  1 jun. 1886Connecticut, USA F26930 AALT 
90 Hubbell / Tuttle  1891Connecticut, USA F12217 AALT 
91 Brainerd / Pattee  30 aug. 1898Connecticut, USA F12239 AALT 
92 Bristol / Humphrey  30 mar. 1904Connecticut, USA F13555 AALT 
93 Yale / Andrews  31 jul. 1907Connecticut, USA F12249 AALT 
94 Kelsey / Gladwin  1908Connecticut, USA F14540 AALT 
95 Friend / Tuttle  1913Connecticut, USA F12251 AALT 
96 Judd / Marvin  1925Connecticut, USA F13032 AALT 
97 Judd / Brown  1926Connecticut, USA F13200 AALT 
98 Story / Brainard  14 apr. 1928Connecticut, USA F12287 AALT 
99 Judd / Hudson  1931Connecticut, USA F13033 AALT 

«Forrige 1 2



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.