Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 151 til 200 fra 469

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
151 Spencer, Catherine  1778Connecticut, USA I11394 AALT 
152 Wightman, Sarah  2 jan. 1778Connecticut, USA I125925 AALT 
153 Palmer, Chloe  13 nov. 1778Connecticut, USA I125667 AALT 
154 Smith, Nathaniel Roswell  24 nov. 1778Connecticut, USA I61018 AALT 
155 Bidwell, Huldah  1779Connecticut, USA I7754 AALT 
156 Hinckley, Polly  1779Connecticut, USA I95471 AALT 
157 Strong, Mary  1779Connecticut, USA I13029 AALT 
158 Smith, Sally Denison  28 aug. 1779Connecticut, USA I35812 AALT 
159 Adgate, Luther  1780Connecticut, USA I43806 AALT 
160 Badcock, Mary Ann  1780Connecticut, USA I77881 AALT 
161 Butler, Lydia  1780Connecticut, USA I38664 AALT 
162 De Wolf, William  1780Connecticut, USA I14794 AALT 
163 Stiles, Jonathan  11 aug. 1780Connecticut, USA I9422 AALT 
164 Spencer, Mary  11 okt. 1780Connecticut, USA I12824 AALT 
165 Adsell, Ruth H  1781Connecticut, USA I48874 AALT 
166 Hinckley, Patty  1781Connecticut, USA I95583 AALT 
167 Gardner, Francis J. Sr.  1782Connecticut, USA I58340 AALT 
168 Johnston, Elizabeth  1782Connecticut, USA I10333 AALT 
169 Lamphere, S  ca. 1782Connecticut, USA I39744 AALT 
170 Stiles, Patty  1782Connecticut, USA I9454 AALT 
171 Coleman, Joseph  1783Connecticut, USA I60803 AALT 
172 Crandall, Jemima  ca. 1783Connecticut, USA I39292 AALT 
173 Hinckley, Charlotte  1783Connecticut, USA I95641 AALT 
174 Pember, Jabez  1783Connecticut, USA I14641 AALT 
175 Brewster, Rebecca  ca. 1784Connecticut, USA I136338 AALT 
176 Judd, Chester S  1784Connecticut, USA I99077 AALT 
177 Keith, Roswell  1784Connecticut, USA I43546 AALT 
178 Pember, Willys  1784Connecticut, USA I14691 AALT 
179 Spencer, Hannah  1784Connecticut, USA I12747 AALT 
180 Hinckley, Sallie  1785Connecticut, USA I95575 AALT 
181 Smith, Lucretia  1786Connecticut, USA I23757 AALT 
182 Hull, Harriet  11 jan. 1786Connecticut, USA I117604 AALT 
183 Philo, Elizabeth  1787Connecticut, USA I25687 AALT 
184 Gurnsey, Samantha  nov. 1787Connecticut, USA I94639 AALT 
185 Potter, Daniel Woodruff  19 dec. 1787Connecticut, USA I30710 AALT 
186 Potter, Merilla  19 dec. 1787Connecticut, USA I28308 AALT 
187 Johnston, Enos  1788Connecticut, USA I10426 AALT 
188 Philo, Asahel  1789Connecticut, USA I12304 AALT 
189 Miles, Mary  1 mar. 1789Connecticut, USA I13572 AALT 
190 Baker, Elizabeth B.  jul. 1789Connecticut, USA I52699 AALT 
191 Shaw, Rhoda  7 jan. 1790Connecticut, USA I66753 AALT 
192 Judd, Elihu  7 dec. 1790Connecticut, USA I51894 AALT 
193 Miles, Jonathan  1791Connecticut, USA I78027 AALT 
194 Treadwell, Allen  1791Connecticut, USA I22520 AALT 
195 Johnston, Susannah  18 maj 1791Connecticut, USA I60327 AALT 
196 Edwards, Catharine Agnes  1792Connecticut, USA I76559 AALT 
197 Lobdell, Esther  7 apr. 1792Connecticut, USA I25005 AALT 
198 Campbell, Dr. Harvey  30 sep. 1792Connecticut, USA I27276 AALT 
199 Bidwell, Electa  28 nov. 1792Connecticut, USA I70867 AALT 
200 Hubbard, Elijah  1793Connecticut, USA I91883 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Næste»



Død

Match 151 til 200 fra 273

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
151 Benjamin, Johnathan  jul. 1800Connecticut, USA I12723 AALT 
152 Perkins, Polydore  19 nov. 1800Connecticut, USA I4461 AALT 
153 Woodward, Hannah  1801Connecticut, USA I9196 AALT 
154 Kingsbury, Irena  13 feb. 1803Connecticut, USA I55730 AALT 
155 Chesebrough, Prudence  29 aug. 1809Connecticut, USA I117678 AALT 
156 Lord, Mehitabel  1810Connecticut, USA I61190 AALT 
157 Smith, Oliver  17 dec. 1810Connecticut, USA I35753 AALT 
158 Paine, Ezra  27 okt. 1811Connecticut, USA I25554 AALT 
159 Spencer, Elizabeth  4 feb. 1812Connecticut, USA I12661 AALT 
160 Hosmer, Ashbel  2 apr. 1812Connecticut, USA I79257 AALT 
161 Arnold, Rhodes  22 jun. 1812Connecticut, USA I74950 AALT 
162 Loomis, Hannah  1815Connecticut, USA I5441 AALT 
163 Knapp, Charity  jan. 1815Connecticut, USA I4928 AALT 
164 Elwell, Grissel  6 jun. 1816Connecticut, USA I261 AALT 
165 Barden, Sarah  28 feb. 1818Connecticut, USA I73276 AALT 
166 Matson, Amy  1820Connecticut, USA I11475 AALT 
167 Loomis, Ursalah  3 nov. 1820Connecticut, USA I11346 AALT 
168 Frink, Eunice  30 nov. 1820Connecticut, USA I43673 AALT 
169 Adams, Lois  21 maj 1821Connecticut, USA I11013 AALT 
170 Adams, William  21 maj 1821Connecticut, USA I11122 AALT 
171 Haven Hemenway, Elizabeth  22 nov. 1821Connecticut, USA I136339 AALT 
172 Linsly, Ebenezer  8 nov. 1822Connecticut, USA I21252 AALT 
173 Cary, Phineas  1824Connecticut, USA I13843 AALT 
174 Hubbard, Aaron  ca. 1824Connecticut, USA I94634 AALT 
175 Williams, Edward  5 jun. 1824Connecticut, USA I75283 AALT 
176 Atwater, Hannah  1825Connecticut, USA I51273 AALT 
177 Crocker, Mary  1825Connecticut, USA I61329 AALT 
178 De Cordova Y Benavides, Maria Joaquina Fernandez  1825Connecticut, USA I118476 AALT 
179 Hubbard, Edmund  1825Connecticut, USA I94612 AALT 
180 Ward, Rebecca  2 apr. 1825Connecticut, USA I42484 AALT 
181 Graves, Elder Josiah  24 jul. 1825Connecticut, USA I87110 AALT 
182 Hooker, Samuel  6 aug. 1825Connecticut, USA I143659 AALT 
183 Mack, Sarah  mar. 1826Connecticut, USA I104277 AALT 
184 Judd, Mercy  27 apr. 1826Connecticut, USA I9048 AALT 
185 Everett, Hannah  3 aug. 1826Connecticut, USA I79102 AALT 
186 Seymour  1827Connecticut, USA I65635 AALT 
187 Phelps, Sarah  30 nov. 1827Connecticut, USA I62257 AALT 
188 Wilcox, Stephen  15 apr. 1828Connecticut, USA I117897 AALT 
189 Stowell, Sarah  1829Connecticut, USA I93843 AALT 
190 Stanton, Cynthia L  15 jan. 1829Connecticut, USA I43963 AALT 
191 Beckwith, Thomas  22 okt. 1829Connecticut, USA I72883 AALT 
192 Merriam, James  eft. nov. 1830Connecticut, USA I31996 AALT 
193 Graves, Margaret  24 apr. 1831Connecticut, USA I24851 AALT 
194 Bradley, Mary  31 mar. 1832Connecticut, USA I84872 AALT 
195 Brace, Captain Abel  20 jun. 1832Connecticut, USA I36273 AALT 
196 Brewster, Thomas  28 okt. 1832Connecticut, USA I15443 AALT 
197 Phelps, Charles E.  22 maj 1833Connecticut, USA I102585 AALT 
198 Pratt, Sarah  5 dec. 1833Connecticut, USA I94557 AALT 
199 Coleman, Joseph  1835Connecticut, USA I60803 AALT 
200 Lindsley, Abigail  9 feb. 1835Connecticut, USA I23881 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.