Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 201 til 250 fra 494

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
201 Shaw, Rhoda  7 jan. 1790Connecticut, USA I66753 AALT 
202 Judd, Elihu  7 dec. 1790Connecticut, USA I51894 AALT 
203 Miles, Jonathan  1791Connecticut, USA I78027 AALT 
204 Treadwell, Allen  1791Connecticut, USA I22520 AALT 
205 Johnston, Susannah  18 maj 1791Connecticut, USA I60327 AALT 
206 Edwards, Catharine Agnes  1792Connecticut, USA I76559 AALT 
207 Lobdell, Esther  7 apr. 1792Connecticut, USA I25005 AALT 
208 Campbell, Dr. Harvey  30 sep. 1792Connecticut, USA I27276 AALT 
209 Bidwell, Electa  28 nov. 1792Connecticut, USA I70867 AALT 
210 Hubbard, Elijah  1793Connecticut, USA I91883 AALT 
211 Keith, Daniel  1793Connecticut, USA I43496 AALT 
212 Mead, Katharine Polly  1793Connecticut, USA I29999 AALT 
213 Miles, Abigail  1793Connecticut, USA I13523 AALT 
214 Spencer, Child  1793Connecticut, USA I15628 AALT 
215 Kirtland, Lucy F.  3 apr. 1793Connecticut, USA I79475 AALT 
216 Clark, Betsey  18 dec. 1793Connecticut, USA I21736 AALT 
217 Churchill, Cynthia  1794Connecticut, USA I100391 AALT 
218 Gates, Nathan  1794Connecticut, USA I4775 AALT 
219 Paddock, George  1794Connecticut, USA I12380 AALT 
220 Parker, Eldad  1794Connecticut, USA I53159 AALT 
221 Hull, Nathaniel  ca. 1795Connecticut, USA I117626 AALT 
222 Bibbins, Lucia  1 apr. 1795Connecticut, USA I13654 AALT 
223 Judd, Eliza  14 maj 1795Connecticut, USA I45329 AALT 
224 Perkins, Mary C.  1796Connecticut, USA I28770 AALT 
225 Wadsworth, Frederick  1796Connecticut, USA I3162 AAP 
226 Brewster, Mary  22 okt. 1796Connecticut, USA I134876 AALT 
227 Johnston, Abraham  1797Connecticut, USA I10151 AALT 
228 Lynde, William Hart  1797Connecticut, USA I110292 AALT 
229 Wadsworth, Chauncey  1797Connecticut, USA I3155 AAP 
230 Webster, Ellsworth  1797Connecticut, USA I11746 AALT 
231 Cooper, Belinda  25 maj 1797Connecticut, USA I20484 AALT 
232 Beckwith, Lot  ca. 1798Connecticut, USA I72675 AALT 
233 Wheeler, William  ca. 1798Connecticut, USA I112556 AALT 
234 Bibbins, Marcia  18 aug. 1798Connecticut, USA I13759 AALT 
235 Brewster, Sally  1799Connecticut, USA I14055 AALT 
236 Wadsworth, Samuel  1799Connecticut, USA I3153 AAP 
237 Webster, Polly  1799Connecticut, USA I11866 AALT 
238 Morse, Caroline  28 sep. 1799Connecticut, USA I24842 AALT 
239 Kimball, Abram  ca. 1800Connecticut, USA I17748 AALT 
240 Wadsworth, Oliver  ca. 1800Connecticut, USA I3167 AAP 
241 Bibbens, Nathaniel C.  7 maj 1800Connecticut, USA I13719 AALT 
242 Wheeler, Edmund  22 jul. 1800Connecticut, USA I46811 AALT 
243 Cook, Mary  1801Connecticut, USA I66209 AALT 
244 Haires, Caroline B  1801Connecticut, USA I91242 AALT 
245 Hull, Lucretia  16 jun. 1801Connecticut, USA I117672 AALT 
246 Armstrong, Rebecca  20 okt. 1801Connecticut, USA I44093 AALT 
247 Allyn, Mary Ann  ca. 1802Connecticut, USA I72653 AALT 
248 Francis, Julia  1802Connecticut, USA I51370 AALT 
249 Thorpe, Justus  ca. 1802Connecticut, USA I74201 AALT 
250 Tuttle, John William  13 sep. 1802Connecticut, USA I42507 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Næste»



Død

Match 201 til 250 fra 276

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
201 Coleman, Joseph  1835Connecticut, USA I60803 AALT 
202 Lindsley, Abigail  9 feb. 1835Connecticut, USA I23881 AALT 
203 Partridge, William  2 okt. 1836Connecticut, USA I40293 AALT 
204 Starr, Fanny  20 aug. 1838Connecticut, USA I40336 AALT 
205 Sedgwick, Jane  1839Connecticut, USA I65586 AALT 
206 Taber, Amelia  14 jan. 1839Connecticut, USA I35904 AALT 
207 Hemingway, Riley J.  17 feb. 1839Connecticut, USA I16476 AALT 
208 Hull, Wyllys Deacon  8 maj 1839Connecticut, USA I117607 AALT 
209 Goodrich, Joel  1840Connecticut, USA I49294 AALT 
210 Spencer, Hannah  13 apr. 1840Connecticut, USA I12763 AALT 
211 Babcock, Phebe  1841Connecticut, USA I95222 AALT 
212 Sedgwick, Charles  30 mar. 1841Connecticut, USA I62530 AALT 
213 Allen, Capt. Capt. Thomas  16 maj 1842Connecticut, USA I35825 AALT 
214 Linsley, Marietta  19 dec. 1842Connecticut, USA I25724 AALT 
215 Grover, Jerusha  20 feb. 1845Connecticut, USA I66860 AALT 
216 Badger, Sarah  19 jul. 1847Connecticut, USA I29953 AALT 
217 Smith, Nancy Ann  1848Connecticut, USA I35761 AALT 
218 Burrows, John Baldwin  3 mar. 1848Connecticut, USA I128372 AALT 
219 Hodge, Phoebe  eft. 1850Connecticut, USA I109 AALT 
220 Lynde, Mary Ann  19 dec. 1851Connecticut, USA I110296 AALT 
221 Fenton, Augusta T  23 mar. 1855Connecticut, USA I115870 AALT 
222 Tanner, Susan Mercelia  12 jun. 1856Connecticut, USA I13600 AALT 
223 Pratt, Cynthia  29 aug. 1856Connecticut, USA I100615 AALT 
224 Throop, William  13 jul. 1857Connecticut, USA I47288 AALT 
225 Burnham, Giles Geles  2 okt. 1858Connecticut, USA I46181 AALT 
226 Peck, Mary  13 aug. 1863Connecticut, USA I37531 AALT 
227 Crawford, Elizabeth  1869Connecticut, USA I91061 AALT 
228 Hemingway, Samuel S  15 feb. 1871Connecticut, USA I7254 AALT 
229 Smith, Sally Denison  14 mar. 1871Connecticut, USA I35812 AALT 
230 Balch, Thomas  1 jul. 1871Connecticut, USA I62802 AALT 
231 Bosworth, Luna  15 mar. 1876Connecticut, USA I42533 AALT 
232 Stoddard, Mary Ann  3 apr. 1877Connecticut, USA I41406 AALT 
233 Peck, Pamelia  1878Connecticut, USA I39196 AALT 
234 Crary, Evelina  1879Connecticut, USA I81017 AALT 
235 Hayes, Asa  23 feb. 1879Connecticut, USA I87040 AALT 
236 Franklin, Richard L.  7 sep. 1880Connecticut, USA I81271 AALT 
237 Marsh, Maria  8 feb. 1881Connecticut, USA I65703 AALT 
238 Brewster, Eugenia Juliet  26 jul. 1883Connecticut, USA I17087 AALT 
239 Watson, Edmund  11 sep. 1883Connecticut, USA I62193 AALT 
240 Hall, Abel L  1884Connecticut, USA I72389 AALT 
241 Lee, Laura L  24 aug. 1887Connecticut, USA I34007 AALT 
242 Peck, Samuel  26 apr. 1888Connecticut, USA I37647 AALT 
243 Bitgood, Joseph Sheffield  1889Connecticut, USA I96244 AALT 
244 Peck, Martha "Patty"  10 aug. 1891Connecticut, USA I37624 AALT 
245 Stanton, Benjamin Franklin  13 maj 1892Connecticut, USA I75365 AALT 
246 Hoadley, Mary Ann  31 mar. 1893Connecticut, USA I136303 AALT 
247 Hester, Terresa J  1 nov. 1893Connecticut, USA I48338 AALT 
248 Miner, Joseph Latham  7 sep. 1894Connecticut, USA I96002 AALT 
249 Kenyon, Phebe Caroline  2 nov. 1896Connecticut, USA I82899 AALT 
250 Andrews, Harriet Gordon  24 okt. 1902Connecticut, USA I96427 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.