Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 1 til 50 fra 469

1 2 3 4 5 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
1 Young, Orrin  ca. 1822Connecticut, USA I84512 AALT 
2 Yeomans, Sarah  1717Connecticut, USA I59674 AALT 
3 Yeoman, Sarah  21 mar. 1700Connecticut, USA I8560 AALT 
4 Yeoman, Moses  1708Connecticut, USA I8383 AALT 
5 Yeoman, Mehetable  1 apr. 1707Connecticut, USA I8799 AALT 
6 Yale, Son  1886Connecticut, USA I63080 AALT 
7 Yale, Helen C  17 jul. 1910Connecticut, USA I74459 AALT 
8 Yale, Fred Thomas Jr  31 maj 1879Connecticut, USA I74418 AALT 
9 Woodruff, Hezekiah  9 aug. 1701Connecticut, USA I76854 AALT 
10 Williams, Mary  1804Connecticut, USA I38864 AALT 
11 Williams, Julia E.  9 mar. 1862Connecticut, USA I60916 AALT 
12 Williams, Ephraim  30 dec. 1850Connecticut, USA I75172 AALT 
13 Wilcox, Mary  1765Connecticut, USA I127806 AALT 
14 Wilcox, Elizabeth M  1 apr. 1824Connecticut, USA I84812 AALT 
15 Wightman, William D  1775Connecticut, USA I46681 AALT 
16 Wightman, Sarah  2 jan. 1778Connecticut, USA I125925 AALT 
17 Wightman, Lucy  17 maj 1772Connecticut, USA I125920 AALT 
18 Wheeler, William  ca. 1798Connecticut, USA I112556 AALT 
19 Wheeler, Merrill  ca. 1807Connecticut, USA I112553 AALT 
20 Wheeler, Edmund  22 jul. 1800Connecticut, USA I46811 AALT 
21 Wheeler, Clarinda C.  1798/1803Connecticut, USA I127848 AALT 
22 Webster, Polly  1799Connecticut, USA I11866 AALT 
23 Webster, Ellsworth  1797Connecticut, USA I11746 AALT 
24 Webb, Josiah  15 mar. 1707Connecticut, USA I28988 AALT 
25 Watson, Seymour  19 jun. 1838Connecticut, USA I65760 AALT 
26 Watson, Sarah Eliza  26 feb. 1829Connecticut, USA I126333 AALT 
27 Watson, Louisa E.  2 mar. 1841Connecticut, USA I65401 AALT 
28 Watson, Isabel Sedgwick  7 jun. 1831Connecticut, USA I65799 AALT 
29 Watson, Barbara Osborne  1914Connecticut, USA I65555 AALT 
30 Wasson, John  9 maj 1759Connecticut, USA I21442 AALT 
31 Warner, Henry  21 aug. 1689Connecticut, USA I13744 AALT 
32 Wargo, Helen E.  1912Connecticut, USA I65630 AALT 
33 Wallace, Barbara Manning  24 maj 1900Connecticut, USA I63050 AALT 
34 Tuttle, William S  1832Connecticut, USA I42460 AALT 
35 Tuttle, Paul Whitney  14 jul. 1908Connecticut, USA I75309 AALT 
36 Tuttle, Osman B  1840Connecticut, USA I42819 AALT 
37 Tuttle, Mary E  1879Connecticut, USA I67424 AALT 
38 Tuttle, Julia M.  1848Connecticut, USA I63377 AALT 
39 Tuttle, Julia Del  1872Connecticut, USA I63431 AALT 
40 Tuttle, Julia Ann  14 feb. 1838Connecticut, USA I109177 AALT 
41 Tuttle, Jonathan  1837Connecticut, USA I42783 AALT 
42 Tuttle, John William  13 sep. 1802Connecticut, USA I42507 AALT 
43 Tuttle, Horace Whitney  7 jun. 1847Connecticut, USA I79943 AALT 
44 Tuttle, Ezra  1838Connecticut, USA I63225 AALT 
45 Tuttle, Albert P  1842Connecticut, USA I42756 AALT 
46 Turlon, William  15 aug. 1858Connecticut, USA I63278 AALT 
47 Tudor, Ann  1654Connecticut, USA I2348 AALT 
48 Trowbridge, Stephan  1745Connecticut, USA I8253 AALT 
49 Trowbridge, Sarah Hoadley  26 mar. 1839Connecticut, USA I78844 AALT 
50 Trowbridge, Sarah  1711Connecticut, USA I46745 AALT 

1 2 3 4 5 ... 10» Næste»



Dåb

Match 1 til 9 fra 9

   Efternavn, Fornavn    Dåb    Person-ID   Træ 
1 Peck, Ruth  3 maj 1696Connecticut, USA I46391 AALT 
2 Patchen, Elizabeth  10 jun. 1744Connecticut, USA I55425 AALT 
3 Owen, Keziah  1724Connecticut, USA I26899 AALT 
4 Loomis, John Deacon  27 aug. 1688Connecticut, USA I60880 AALT 
5 Lay, Abigail  28 mar. 1773Connecticut, USA I91651 AALT 
6 Hart, Azuba  16 sep. 1792Connecticut, USA I71428 AALT 
7 Filley, Deborah  24 nov. 1661Connecticut, USA I54272 AALT 
8 Edwards, Jonathan  Connecticut, USA I140266 AALT 
9 Babcock, William Robinson  Connecticut, USA I74972 AALT 

Død

Match 1 til 50 fra 273

1 2 3 4 5 ... Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
1 Woodward, Hannah  1801Connecticut, USA I9196 AALT 
2 Williams, Hannah  eft. 4 okt. 1749Connecticut, USA I94608 AALT 
3 Williams, Edward  5 jun. 1824Connecticut, USA I75283 AALT 
4 Wilcox, Stephen  15 apr. 1828Connecticut, USA I117897 AALT 
5 Welles, Mary  1647Connecticut, USA I33463 AALT 
6 Watson, Edmund  11 sep. 1883Connecticut, USA I62193 AALT 
7 Ward, Rebecca  2 apr. 1825Connecticut, USA I42484 AALT 
8 Ward, Diantha  1771Connecticut, USA I21936 AALT 
9 Ward, Deborah  Connecticut, USA I42324 AALT 
10 Ward, Ambrose  14 nov. 1739Connecticut, USA I42481 AALT 
11 Throop, William  13 jul. 1857Connecticut, USA I47288 AALT 
12 Thompson, John  14 okt. 1688Connecticut, USA I32185 AALT 
13 Tanner, William Warren  23 aug. 1911Connecticut, USA I80570 AALT 
14 Tanner, Susan Mercelia  12 jun. 1856Connecticut, USA I13600 AALT 
15 Tanner, Luther S.  1927Connecticut, USA I80674 AALT 
16 Tanner, Emma C.  Connecticut, USA I80641 AALT 
17 Talmadge, Kezia  1737Connecticut, USA I57875 AALT 
18 Taber, Amelia  14 jan. 1839Connecticut, USA I35904 AALT 
19 Stowell, Sarah  1829Connecticut, USA I93843 AALT 
20 Stoddard, Mary Ann  3 apr. 1877Connecticut, USA I41406 AALT 
21 Stevens, Mary  1765Connecticut, USA I110 AALT 
22 Stevens, Mabel  1765Connecticut, USA I363 AALT 
23 Stevens, Esther  1765Connecticut, USA I191 AALT 
24 Starr, Fanny  20 aug. 1838Connecticut, USA I40336 AALT 
25 Stanton, Cynthia L  15 jan. 1829Connecticut, USA I43963 AALT 
26 Stanton, Benjamin Franklin  13 maj 1892Connecticut, USA I75365 AALT 
27 Stacy, Susan Ann  1703Connecticut, USA I18236 AALT 
28 Spencer, Hannah  13 apr. 1840Connecticut, USA I12763 AALT 
29 Spencer, Elizabeth  4 feb. 1812Connecticut, USA I12661 AALT 
30 Smith, Sally Denison  14 mar. 1871Connecticut, USA I35812 AALT 
31 Smith, Richard  1749Connecticut, USA I102279 AALT 
32 Smith, Oliver  17 dec. 1810Connecticut, USA I35753 AALT 
33 Smith, Nancy Ann  1848Connecticut, USA I35761 AALT 
34 Seymour Jr., David Jr.  Connecticut, USA I70939 AALT 
35 Seymour, Thankful  jun. 1790Connecticut, USA I66656 AALT 
36 Seymour, Ira  1800Connecticut, USA I70839 AALT 
37 Seymour  1827Connecticut, USA I65635 AALT 
38 Sedgwick, Jane  1839Connecticut, USA I65586 AALT 
39 Sedgwick, Charles  30 mar. 1841Connecticut, USA I62530 AALT 
40 Searles, Ebenezer  Connecticut, USA I38004 AALT 
41 Seaman, Jane E.  1918Connecticut, USA I51274 AALT 
42 Sampson, Priscilla Andrus  25 apr. 1783Connecticut, USA I135728 AALT 
43 Sabin, Hezekiah  ca. 1762Connecticut, USA I37761 AALT 
44 Sabin, Ethan  Connecticut, USA I37772 AALT 
45 Sabin, Esther  Connecticut, USA I37705 AALT 
46 Sabin, Dorothy  Connecticut, USA I37887 AALT 
47 Russell, Abigail  1775Connecticut, USA I18162 AALT 
48 Rudd, Nathaniel  12 jul. 1752Connecticut, USA I25438 AALT 
49 Rollo, William  30 maj 1732Connecticut, USA I104381 AALT 
50 Prout, Margaret  1720Connecticut, USA I137646 AALT 

1 2 3 4 5 ... Næste»



Begravelse

Match 1 til 50 fra 83

1 2 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Begravelse    Person-ID   Træ 
1 Woodruff, Philo  Connecticut, USA I35251 AALT 
2 Whittemore, Alvan Fosdick  Connecticut, USA I94556 AALT 
3 Whitmore, Elizabeth  Connecticut, USA I94664 AALT 
4 Tudor, Mary  Connecticut, USA I13422 AALT 
5 Timmerman, William Orton  Connecticut, USA I66058 AALT 
6 Tarbox, Sarah  aug. 1754Connecticut, USA I29453 AALT 
7 Tanner, Susan Mercelia  Connecticut, USA I13600 AALT 
8 Tanner, Joseph  Connecticut, USA I27287 AALT 
9 Storrs, Hannah  Connecticut, USA I52043 AALT 
10 Spencer, Roswell  1806Connecticut, USA I27012 AALT 
11 Spencer, Elizabeth  Connecticut, USA I126813 AALT 
12 Simmons, Abigail  Connecticut, USA I10633 AALT 
13 Shepard, Isaac  Connecticut, USA I117719 AALT 
14 Sanford, Susan Alice  Connecticut, USA I64065 AALT 
15 Sanford, Robert  Connecticut, USA I60449 AALT 
16 Preston, Esther  Connecticut, USA I87032 AALT 
17 Pratt, Hepsibah  Connecticut, USA I94594 AALT 
18 Pratt, Elisabeth  Connecticut, USA I94584 AALT 
19 Phelps, Captain Samuel  okt. 1741Connecticut, USA I103455 AALT 
20 Pease, John  jun. 1761Connecticut, USA I86584 AALT 
21 Pease, John  jun. 1761Connecticut, USA I86334 AALT 
22 Parmalee, Mildred Ives  Connecticut, USA I62899 AALT 
23 Parmalee, Charles Ives  Connecticut, USA I62578 AALT 
24 Parke, Hezekiah  feb. 1752Connecticut, USA I24977 AALT 
25 Noyes, James Jr.  1718Connecticut, USA I35330 AALT 
26 North, Hannah  Connecticut, USA I29702 AALT 
27 Morgan, Sarah  Connecticut, USA I134337 AALT 
28 Morgan, John Jr.  Connecticut, USA I136328 AALT 
29 Morgan, John Jr.  Connecticut, USA I27224 AALT 
30 Morgan, George W  1865Connecticut, USA I135810 AALT 
31 Morgan, Daniel  Connecticut, USA I135785 AALT 
32 Metcalfe, Simeon  Connecticut, USA I26966 AALT 
33 Meach, Moses  Connecticut, USA I27221 AALT 
34 Marvin, Martha  Connecticut, USA I126248 AALT 
35 Loomis, Hannah  okt. 1778Connecticut, USA I5247 AALT 
36 Linsly, Ebenezer  Connecticut, USA I21252 AALT 
37 Kirtland, George  Connecticut, USA I63005 AALT 
38 Kirtland, Delight  Connecticut, USA I63101 AALT 
39 Kirtland, Clarissa  Connecticut, USA I63683 AALT 
40 Kirtland, Dr. Billius  Connecticut, USA I66967 AALT 
41 Kellogg, Margaret  Connecticut, USA I13013 AALT 
42 Judd, Katharine Welles  Connecticut, USA I65854 AALT 
43 Judd, George Morton  Connecticut, USA I65859 AALT 
44 Judd, Gardiner Wells  Connecticut, USA I68966 AALT 
45 Judd, Alice May  Connecticut, USA I65858 AALT 
46 Hull, Wyllys Deacon  Connecticut, USA I117607 AALT 
47 Hodge, Peggy  Connecticut, USA I9367 AALT 
48 Hemingway, Samuel  Connecticut, USA I73261 AALT 
49 Hanchett, Deliverance Hannah  nov. 1711Connecticut, USA I46003 AALT 
50 Hall, David M.  Connecticut, USA I63122 AALT 

1 2 Næste»



Arrival

Match 1 til 3 fra 3

   Efternavn, Fornavn    Arrival    Person-ID   Træ 
1 Churchill, Josiah  1635Connecticut, USA I21766 AALT 
2 Champion, Henry  1647Connecticut, USA I54477 AALT 
3 Blakeslee, Samuel  1650Connecticut, USA I22909 AALT 

Bopæl

Match 1 til 17 fra 17

   Efternavn, Fornavn    Bopæl    Person-ID   Træ 
1 Woodruff, Newton  1870Connecticut, USA I35151 AALT 
2 Tudor, Owen  Connecticut, USA I22654 AALT 
3 Teneyke, Elizabeth J.  Connecticut, USA I107826 AALT 
4 Tanner, George Allen  1870Connecticut, USA I80688 AALT 
5 Smith, Maria  1870Connecticut, USA I94686 AALT 
6 Pardee, David Hunter  Connecticut, USA I142182 AALT 
7 Pardee, Daniel Johns  Connecticut, USA I142187 AALT 
8 Henshaw, William  Connecticut, USA I113525 AALT 
9 Henshaw, William  Connecticut, USA I113525 AALT 
10 Henshaw, Benjamin  1818Connecticut, USA I112516 AALT 
11 Gaylord, William  ml. 1650 og 1800Connecticut, USA I19443 AALT 
12 Ford, Benoni  1778Connecticut, USA I107565 AALT 
13 Denison, Ann Elizabeth  1870Connecticut, USA I33438 AALT 
14 Babcock, Stephen Tyng  1870Connecticut, USA I55367 AALT 
15 Babcock, Mary Denison  1870Connecticut, USA I75187 AALT 
16 Babcock, Lucy Bell  1870Connecticut, USA I59181 AALT 
17 Babcock, Lucy Bell  1870Connecticut, USA I33346 AALT 

Dåb

Match 1 til 1 fra 1

   Efternavn, Fornavn    Dåb    Person-ID   Træ 
1 Peck, Ruth  3 maj 1696Connecticut, USA I46391 AALT 

Død

Match 1 til 2 fra 2

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
1 Gibbs, Lydia  1765Connecticut, USA I87010 AALT 
2 Dyer, Mary  20 dec. 1740Connecticut, USA I49623 AALT 

Fødsel

Match 1 til 7 fra 7

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
1 Williams, Ephraim  1875Connecticut, USA I75017 AALT 
2 Wightman, Uriah  1775Connecticut, USA I46621 AALT 
3 Stebbins, Isabella  1687Connecticut, USA I62205 AALT 
4 Hart, Ezra  17 maj 1801Connecticut, USA I125958 AALT 
5 Drake, Abraham  1784Connecticut, USA I52326 AALT 
6 Amidon, Eunice  1784Connecticut, USA I127205 AALT 
7 Amidon, Eunice  1784Connecticut, USA I127205 AALT 

Indvandring

Match 1 til 2 fra 2

   Efternavn, Fornavn    Indvandring    Person-ID   Træ 
1 Sherwood, Thomas  apr. 1634Connecticut, USA I57631 AALT 
2 Pond, Samuel I  1630Connecticut, USA I139150 AALT 

Obituary

Match 1 til 1 fra 1

   Efternavn, Fornavn    Obituary    Person-ID   Træ 
1 Sedgwick, Ruth Joy  23 jan. 2004Connecticut, USA I36254 AALT 

_MILT

Match 1 til 9 fra 9

   Efternavn, Fornavn    _MILT    Person-ID   Træ 
1 Sherwood, Thomas  Connecticut, USA I57631 AALT 
2 Rodgers, Abijah  1 aug. 1777Connecticut, USA I87051 AALT 
3 Prichard, Benjamin III  26 apr. 1777Connecticut, USA I100097 AALT 
4 Pratt, Benjamin Jr.  ml. 1755 og 1762Connecticut, USA I91742 AALT 
5 Pease, David  6 aug. 1782Connecticut, USA I86583 AALT 
6 Pease, David  jun. 1782Connecticut, USA I86583 AALT 
7 Pardee, Jonathan  19 okt. 1777Connecticut, USA I142176 AALT 
8 Herrick, Amos  Connecticut, USA I98758 AALT 
9 Henshaw, William  14 dec. 1779Connecticut, USA I113525 AALT 

Ægteskab

Match 1 til 50 fra 99

1 2 Næste»

   Familie    Ægteskab    Familie-ID   Træ 
1 Yale / Wilcox Yale  18 dec. 1867Connecticut, USA F12115 AALT 
2 Yale / Kirtland  23 jul. 1822Connecticut, USA F14260 AALT 
3 Yale / Andrews  31 jul. 1907Connecticut, USA F12249 AALT 
4 Woodruff / Mason  3 dec. 1730Connecticut, USA F16348 AALT 
5 Weeks / Armstrong  1726Connecticut, USA F3909 AALT 
6 Tuttle / Beecher  1847Connecticut, USA F12182 AALT 
7 Tuttle / Beecher  1834Connecticut, USA F17020 AALT 
8 Thompson / Lathrop  1683Connecticut, USA F15965 AALT 
9 Terry / Sanford  2 sep. 1865Connecticut, USA F12485 AALT 
10 Tanner / Campbell  17 okt. 1857Connecticut, USA F4733 AALT 
11 Stoughton / Ellsworth  1769Connecticut, USA F10588 AALT 
12 Story / Brainard  14 apr. 1928Connecticut, USA F12287 AALT 
13 Stevens / Peck  1714Connecticut, USA F229 AALT 
14 Stevens / Hodges  5 dec. 1742Connecticut, USA F330 AALT 
15 Stanton / Palmer  ca. 1778Connecticut, USA F2120 AALT 
16 Stanton / Dennison  16 jun. 1680Connecticut, USA F8615 AALT 
17 Spencer / Clark  1730Connecticut, USA F4734 AALT 
18 Spencer / Booth  28 feb. 1699Connecticut, USA F4009 AALT 
19 Smith / Burrows  6 mar. 1788Connecticut, USA F7446 AALT 
20 Shepard / Angell  1817Connecticut, USA F6003 AALT 
21 Seymour / Hoadley  17 sep. 1836Connecticut, USA F30565 AALT 
22 Sedgwick / Webster Mix  jun. 1820Connecticut, USA F12718 AALT 
23 Sedgwick / Tyler  1744Connecticut, USA F12021 AALT 
24 Sedgwick / Merriam  8 maj 1819Connecticut, USA F11868 AALT 
25 Sedgwick / Ensign  17 okt. 1825Connecticut, USA F11915 AALT 
26 Rudd / Lathrop  1772Connecticut, USA F3705 AALT 
27 Root / Hemingway  1816Connecticut, USA F2255 AALT 
28 Porter / Snow  26 dec. 1728Connecticut, USA F1242 AALT 
29 Phelps / Wilson  4 jun. 1646Connecticut, USA F21042 AALT 
30 Phelps / Randall  30 nov. 1648Connecticut, USA F26639 AALT 
31 Phelps / Denison  10 sep. 1757Connecticut, USA F16033 AALT 
32 Paine / Ellsworth  1769Connecticut, USA F3899 AALT 
33 Moulthrop / Way  22 jun. 1745Connecticut, USA F284 AALT 
34 Moore / Pember  1867Connecticut, USA F13147 AALT 
35 Monson / Todd  11 nov. 1868Connecticut, USA F11811 AALT 
36 Mix / Goodwin  1747Connecticut, USA F15033 AALT 
37 Merriam / Parker  1798Connecticut, USA F6762 AALT 
38 Lyon / Page  6 maj 1848Connecticut, USA F30162 AALT 
39 Lovegrove / Fillmore  1775Connecticut, USA F6534 AALT 
40 Loomis / Cook  eft. 1691Connecticut, USA F11554 AALT 
41 Loomis / Brewster  mar. 1806Connecticut, USA F30138 AALT 
42 Lane / Carrington  jul. 1855Connecticut, USA F12101 AALT 
43 Kirtland / Stannard  1846Connecticut, USA F12289 AALT 
44 Kirtland / Carrington  22 feb. 1819Connecticut, USA F12237 AALT 
45 Kirtland / Benham  4 jul. 1829Connecticut, USA F12065 AALT 
46 Kelsey / Gladwin  1908Connecticut, USA F14540 AALT 
47 Kellogg / Phelps  1766Connecticut, USA F24022 AALT 
48 Judd / Welles  25 apr. 1855Connecticut, USA F13054 AALT 
49 Judd / Marvin  1925Connecticut, USA F13032 AALT 
50 Judd / Hudson  1931Connecticut, USA F13033 AALT 

1 2 Næste»



Viet

Match 1 til 5 fra 5

   Familie    Viet    Familie-ID   Træ 
1 Ogden / Baldwin  1745Connecticut, USA F16216 AALT 
2 Loomis / Holbrook  27 sep. 1743Connecticut, USA F8985 AALT 
3 Hooker / Webster  ca. 1735Connecticut, USA F16278 AALT 
4 Bidwell / Wilcox  1647Connecticut, USA F11517 AALT 
5 Babcock / Denison  13 okt. 1832Connecticut, USA F7089 AALT 

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.