My family research project.

Connecticut, USA



 


Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 201 til 250 fra 469

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
201 Hinckley, Patty  1781Connecticut, USA I95583 AALT 
202 Hinckley, Polly  1779Connecticut, USA I95471 AALT 
203 Hinckley, Sallie  1785Connecticut, USA I95575 AALT 
204 Hitchcock, Jane  5 maj 1812Connecticut, USA I78650 AALT 
205 Hodges, Rebecca  1751Connecticut, USA I71 AALT 
206 Hogarty, Mary Emily  28 sep. 1863Connecticut, USA I96219 AALT 
207 Holcomb, Deborah  10 feb. 1673Connecticut, USA I32048 AALT 
208 Holmes, Mariva E  1816Connecticut, USA I62197 AALT 
209 Honer, Martin Joseph  1875Connecticut, USA I62510 AALT 
210 Honor, Josephine  1903Connecticut, USA I67304 AALT 
211 Hooker, Ruth  16 apr. 1708Connecticut, USA I143840 AALT 
212 Hooker, Susannah  1688Connecticut, USA I143862 AALT 
213 Hopkins, Emily A.  17 apr. 1862Connecticut, USA I63108 AALT 
214 Hopkins, Sarah  ca. 1750Connecticut, USA I30943 AALT 
215 Hotchkiss, Edgar Eugene  1843Connecticut, USA I63400 AALT 
216 Hotchkiss, Roswell  1806Connecticut, USA I63493 AALT 
217 Hough, Jennie Blakeslee  5 jan. 1864Connecticut, USA I63319 AALT 
218 Howard, Lois  1775Connecticut, USA I41459 AALT 
219 Hubbard, Elijah  1793Connecticut, USA I91883 AALT 
220 Hubbard, John  12 apr. 1655Connecticut, USA I27202 AALT 
221 Hubbard, Joseph B.  1807Connecticut, USA I94628 AALT 
222 Hubbard, Rebecca  1700Connecticut, USA I13326 AALT 
223 Hubbard, Timothy B  1810Connecticut, USA I94616 AALT 
224 Hubbell, Mabel T.  1903Connecticut, USA I63251 AALT 
225 Hull, Harriet  11 jan. 1786Connecticut, USA I117604 AALT 
226 Hull, Lucretia  16 jun. 1801Connecticut, USA I117672 AALT 
227 Hull, Nathaniel  ca. 1795Connecticut, USA I117626 AALT 
228 Hull, Sarah  7 okt. 1765Connecticut, USA I117623 AALT 
229 Humason, Joel  1758Connecticut, USA I1157 AALT 
230 Humphrey, Emma Louise  12 apr. 1881Connecticut, USA I67245 AALT 
231 Humphrey, George Frederick  11 feb. 1814Connecticut, USA I67104 AALT 
232 Humphrey, George Harvey  21 mar. 1830Connecticut, USA I4424 AALT 
233 Humphrey, Helen G  jun. 1884Connecticut, USA I67078 AALT 
234 Hutchinson, Adelaide  1842Connecticut, USA I46996 AALT 
235 Hutchinson, Ellen  1846Connecticut, USA I46955 AALT 
236 Hutchinson, Hiram  1847Connecticut, USA I46960 AALT 
237 Hutchinson, Leroy  dec. 1849Connecticut, USA I46967 AALT 
238 Ireland, Sarah Coe  1880Connecticut, USA I87938 AALT 
239 Jennings, Ethel M.  okt. 1886Connecticut, USA I136261 AALT 
240 Johnson, Ruth  3 apr. 1667Connecticut, USA I19381 AALT 
241 Johnston, Abraham  1797Connecticut, USA I10151 AALT 
242 Johnston, Elizabeth  1782Connecticut, USA I10333 AALT 
243 Johnston, Enos  1788Connecticut, USA I10426 AALT 
244 Johnston, Susannah  18 maj 1791Connecticut, USA I60327 AALT 
245 Jones, Ebenezer  1732Connecticut, USA I8867 AALT 
246 Judd, Alice Lucile  1895Connecticut, USA I66008 AALT 
247 Judd, Chester S  1784Connecticut, USA I99077 AALT 
248 Judd, Elihu  7 dec. 1790Connecticut, USA I51894 AALT 
249 Judd, Eliza  14 maj 1795Connecticut, USA I45329 AALT 
250 Judd, Nancy  21 okt. 1927Connecticut, USA I65786 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Næste»



Død

Match 201 til 250 fra 273

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
201 Palmer, Thankful  Connecticut, USA I4448 AALT 
202 Partridge, William  2 okt. 1836Connecticut, USA I40293 AALT 
203 Pattee, Susan E.  28 jun. 1998Connecticut, USA I68561 AALT 
204 Peck, Martha "Patty"  10 aug. 1891Connecticut, USA I37624 AALT 
205 Peck, Mary  13 aug. 1863Connecticut, USA I37531 AALT 
206 Peck, Pamelia  1878Connecticut, USA I39196 AALT 
207 Peck, Ruth  29 mar. 1728Connecticut, USA I46391 AALT 
208 Peck, Samuel  26 apr. 1888Connecticut, USA I37647 AALT 
209 Peet, Abijah  1782Connecticut, USA I93841 AALT 
210 Pember, Jane King  9 dec. 1909Connecticut, USA I65860 AALT 
211 Perkins, John  1800Connecticut, USA I23673 AALT 
212 Perkins, Polydore  19 nov. 1800Connecticut, USA I4461 AALT 
213 Phelps, Alexander  1773Connecticut, USA I126942 AALT 
214 Phelps, Charles E.  22 maj 1833Connecticut, USA I102585 AALT 
215 Phelps, Mehitable  1752Connecticut, USA I126947 AALT 
216 Phelps, Sarah  30 nov. 1827Connecticut, USA I62257 AALT 
217 Porter, Experience  28 okt. 1744Connecticut, USA I57556 AALT 
218 Pratt, Cynthia  29 aug. 1856Connecticut, USA I100615 AALT 
219 Pratt, David Jr.  eft. 1766Connecticut, USA I38999 AALT 
220 Pratt, Nathaniel  1744Connecticut, USA I165 AALT 
221 Pratt, Nn  1790Connecticut, USA I20217 AALT 
222 Pratt, Nn  1790Connecticut, USA I16058 AALT 
223 Pratt, Sarah  5 dec. 1833Connecticut, USA I94557 AALT 
224 Prout, Margaret  1720Connecticut, USA I137646 AALT 
225 Rollo, William  30 maj 1732Connecticut, USA I104381 AALT 
226 Rudd, Nathaniel  12 jul. 1752Connecticut, USA I25438 AALT 
227 Russell, Abigail  1775Connecticut, USA I18162 AALT 
228 Sabin, Dorothy  Connecticut, USA I37887 AALT 
229 Sabin, Esther  Connecticut, USA I37705 AALT 
230 Sabin, Ethan  Connecticut, USA I37772 AALT 
231 Sabin, Hezekiah  ca. 1762Connecticut, USA I37761 AALT 
232 Sampson, Priscilla Andrus  25 apr. 1783Connecticut, USA I135728 AALT 
233 Seaman, Jane E.  1918Connecticut, USA I51274 AALT 
234 Searles, Ebenezer  Connecticut, USA I38004 AALT 
235 Sedgwick, Charles  30 mar. 1841Connecticut, USA I62530 AALT 
236 Sedgwick, Jane  1839Connecticut, USA I65586 AALT 
237 Seymour  1827Connecticut, USA I65635 AALT 
238 Seymour, Ira  1800Connecticut, USA I70839 AALT 
239 Seymour, Thankful  jun. 1790Connecticut, USA I66656 AALT 
240 Seymour Jr., David Jr.  Connecticut, USA I70939 AALT 
241 Smith, Nancy Ann  1848Connecticut, USA I35761 AALT 
242 Smith, Oliver  17 dec. 1810Connecticut, USA I35753 AALT 
243 Smith, Richard  1749Connecticut, USA I102279 AALT 
244 Smith, Sally Denison  14 mar. 1871Connecticut, USA I35812 AALT 
245 Spencer, Elizabeth  4 feb. 1812Connecticut, USA I12661 AALT 
246 Spencer, Hannah  13 apr. 1840Connecticut, USA I12763 AALT 
247 Stacy, Susan Ann  1703Connecticut, USA I18236 AALT 
248 Stanton, Benjamin Franklin  13 maj 1892Connecticut, USA I75365 AALT 
249 Stanton, Cynthia L  15 jan. 1829Connecticut, USA I43963 AALT 
250 Starr, Fanny  20 aug. 1838Connecticut, USA I40336 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af John Lynge.