Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 251 til 300 fra 494

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
251 Gates, Oliver Uriah  9 okt. 1802Connecticut, USA I4826 AALT 
252 Bibbins, Lucretia  1803Connecticut, USA I13557 AALT 
253 Wheeler, Clarinda C.  1798/1803Connecticut, USA I127848 AALT 
254 Beckwith, Phoebe (Barber)  ca. 1804Connecticut, USA I72828 AALT 
255 Williams, Mary  1804Connecticut, USA I38864 AALT 
256 Bibbins, Laura  1806Connecticut, USA I13624 AALT 
257 Hotchkiss, Roswell  1806Connecticut, USA I63493 AALT 
258 Isham, Rosanna  16 apr. 1806Connecticut, USA I3168 AAP 
259 Cook, Harriet P.  1807Connecticut, USA I67603 AALT 
260 Daniels, Amherst  1807Connecticut, USA I63263 AALT 
261 Hubbard, Joseph B.  1807Connecticut, USA I94628 AALT 
262 Merwin, Nathaniel Royal  ml. 1807 og 1808Connecticut, USA I78608 AALT 
263 Wheeler, Merrill  ca. 1807Connecticut, USA I112553 AALT 
264 Loomis, Jerusha Brewster  14 apr. 1807Connecticut, USA I136335 AALT 
265 Dyer  1808Connecticut, USA I66609 AALT 
266 Hathaway, Orson B  22 maj 1808Connecticut, USA I43545 AALT 
267 Emmons, Amanda  1809Connecticut, USA I20643 AALT 
268 Hall, Isaac Kirtland  20 mar. 1809Connecticut, USA I63356 AALT 
269 Hubbard, Timothy B  1810Connecticut, USA I94616 AALT 
270 Pratt, Maria  1810Connecticut, USA I94520 AALT 
271 Seaman, Sellinda  1810Connecticut, USA I46873 AALT 
272 Brace, Edmund  1811Connecticut, USA I41632 AALT 
273 Seymour, George  1811Connecticut, USA I136299 AALT 
274 Bibbins, Maria  nov. 1811Connecticut, USA I13567 AALT 
275 Edwards, George William  1 nov. 1811Connecticut, USA I75242 AALT 
276 Hitchcock, Jane  5 maj 1812Connecticut, USA I78650 AALT 
277 Cary, Lucius Henry  1813Connecticut, USA I33062 AALT 
278 Hall, Lucy A  1813Connecticut, USA I62863 AALT 
279 Kingsley, Eleanor Mariah  28 jan. 1813Connecticut, USA I108920 AALT 
280 Loomis, Martha Wadsworth  26 okt. 1813Connecticut, USA I136334 AALT 
281 Thomas, Nathan  1814Connecticut, USA I63467 AALT 
282 Humphrey, George Frederick  11 feb. 1814Connecticut, USA I67104 AALT 
283 Kingsley, Harriet  3 mar. 1814Connecticut, USA I108918 AALT 
284 Hall, Abel L  6 mar. 1815Connecticut, USA I72389 AALT 
285 Seymour, Ann Maria  10 jul. 1815Connecticut, USA I65580 AALT 
286 Hall, Dalia Charlotte  6 okt. 1815Connecticut, USA I63334 AALT 
287 Babcock, Lucy Bell  1816Connecticut, USA I84855 AALT 
288 Holmes, Mariva E  1816Connecticut, USA I62197 AALT 
289 Parsons, Mary Ann  1816Connecticut, USA I63778 AALT 
290 Seymour, Wellington  1816Connecticut, USA I65371 AALT 
291 Babcock, William D  1 maj 1816Connecticut, USA I56492 AALT 
292 Bidwell, Erastus Frank  13 dec. 1816Connecticut, USA I67058 AALT 
293 Cook, Jane  1817Connecticut, USA I63205 AALT 
294 Shelden, Adeline  1817Connecticut, USA I43799 AALT 
295 Shepard, Caleb A.  1818Connecticut, USA I14126 AALT 
296 Hall, David M.  27 maj 1818Connecticut, USA I63122 AALT 
297 Benson, Henry Edward  1819Connecticut, USA I65969 AALT 
298 Dunning, Charity  1819Connecticut, USA I81063 AALT 
299 Seymour  1819Connecticut, USA I65635 AALT 
300 Merriman, George Isaac  20 feb. 1820Connecticut, USA I72459 AALT 

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»



Død

Match 251 til 276 fra 276

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
251 Hemingway, Esther B  3 jun. 1903Connecticut, USA I7307 AALT 
252 Hemingway, Jacob Willis  20 maj 1905Connecticut, USA I28289 AALT 
253 Bixby, Joseph Edward  12 okt. 1905Connecticut, USA I38111 AALT 
254 Bidwell, Frederick Albert  1907Connecticut, USA I67274 AALT 
255 Pember, Jane King  9 dec. 1909Connecticut, USA I65860 AALT 
256 Hogarty, Mary Emily  17 aug. 1910Connecticut, USA I96219 AALT 
257 Tanner, William Warren  23 aug. 1911Connecticut, USA I80570 AALT 
258 Moore, Col. Samuel A.  11 maj 1912Connecticut, USA I65982 AALT 
259 Elwell, Angeline  9 maj 1914Connecticut, USA I10700 AALT 
260 Seaman, Jane E.  1918Connecticut, USA I51274 AALT 
261 Manning, Sarah Rose  21 feb. 1918Connecticut, USA I62695 AALT 
262 Bidwell, George Edmund  1922Connecticut, USA I69110 AALT 
263 Bidwell, Grove Sherman  1926Connecticut, USA I67343 AALT 
264 Tanner, Luther S.  1927Connecticut, USA I80674 AALT 
265 Judd, Nancy  27 okt. 1927Connecticut, USA I65786 AALT 
266 Marvin, Martha  21 jun. 1930Connecticut, USA I126248 AALT 
267 Hemingway, Willis J.  4 nov. 1931Connecticut, USA I14814 AALT 
268 North, Sarah Maria  1935Connecticut, USA I67202 AALT 
269 Bitgood, Frederick Ellsworth  21 jan. 1938Connecticut, USA I96107 AALT 
270 Schuetz, Henry August Jr  10 dec. 1955Connecticut, USA I759 AAP 
271 Goodenough, Priscilla Pauline  25 nov. 1959Connecticut, USA I65847 AALT 
272 Goodenough, Giles Frederick  jan. 1960Connecticut, USA I65816 AALT 
273 Hart, Lena May  1963Connecticut, USA I67235 AALT 
274 Millington, Catherine  1978Connecticut, USA I134445 AALT 
275 Brainard, Mary Louise  28 sep. 1989Connecticut, USA I63523 AALT 
276 Pattee, Susan E.  28 jun. 1998Connecticut, USA I68561 AALT 

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.