Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 251 til 300 fra 494

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
251 Johnson, Ruth  3 apr. 1667Connecticut, USA I19381 AALT 
252 Jennings, Ethel M.  okt. 1886Connecticut, USA I136261 AALT 
253 Isham, Rosanna  16 apr. 1806Connecticut, USA I3168 AAP 
254 Ireland, Sarah Coe  1880Connecticut, USA I87938 AALT 
255 Hutchinson, Leroy  dec. 1849Connecticut, USA I46967 AALT 
256 Hutchinson, Hiram  1847Connecticut, USA I46960 AALT 
257 Hutchinson, Ellen  1846Connecticut, USA I46955 AALT 
258 Hutchinson, Adelaide  1842Connecticut, USA I46996 AALT 
259 Humphrey, Helen G  jun. 1884Connecticut, USA I67078 AALT 
260 Humphrey, George Harvey  21 mar. 1830Connecticut, USA I4424 AALT 
261 Humphrey, George Frederick  11 feb. 1814Connecticut, USA I67104 AALT 
262 Humphrey, Emma Louise  12 apr. 1881Connecticut, USA I67245 AALT 
263 Humason, Joel  1758Connecticut, USA I1157 AALT 
264 Hull, Sarah  7 okt. 1765Connecticut, USA I117623 AALT 
265 Hull, Nathaniel  ca. 1795Connecticut, USA I117626 AALT 
266 Hull, Lucretia  16 jun. 1801Connecticut, USA I117672 AALT 
267 Hull, Harriet  11 jan. 1786Connecticut, USA I117604 AALT 
268 Hubbell, Mabel T.  1903Connecticut, USA I63251 AALT 
269 Hubbard, Timothy B  1810Connecticut, USA I94616 AALT 
270 Hubbard, Rebecca  1700Connecticut, USA I13326 AALT 
271 Hubbard, Joseph B.  1807Connecticut, USA I94628 AALT 
272 Hubbard, John  12 apr. 1655Connecticut, USA I27202 AALT 
273 Hubbard, Elijah  1793Connecticut, USA I91883 AALT 
274 Howard, Lois  1775Connecticut, USA I41459 AALT 
275 Hough, Jennie Blakeslee  5 jan. 1864Connecticut, USA I63319 AALT 
276 Hotchkiss, Roswell  1806Connecticut, USA I63493 AALT 
277 Hotchkiss, Edgar Eugene  1843Connecticut, USA I63400 AALT 
278 Hopkins, Sarah  ca. 1750Connecticut, USA I30943 AALT 
279 Hopkins, Emily A.  17 apr. 1862Connecticut, USA I63108 AALT 
280 Hooker, Susannah  1688Connecticut, USA I143862 AALT 
281 Hooker, Ruth  16 apr. 1708Connecticut, USA I143840 AALT 
282 Honor, Josephine  1903Connecticut, USA I67304 AALT 
283 Honer, Martin Joseph  1875Connecticut, USA I62510 AALT 
284 Holmes, Mariva E  1816Connecticut, USA I62197 AALT 
285 Holcomb, Deborah  10 feb. 1673Connecticut, USA I32048 AALT 
286 Hogarty, Mary Emily  28 sep. 1863Connecticut, USA I96219 AALT 
287 Hodges, Rebecca  1751Connecticut, USA I71 AALT 
288 Hitchcock, Jane  5 maj 1812Connecticut, USA I78650 AALT 
289 Hinckley, Sallie  1785Connecticut, USA I95575 AALT 
290 Hinckley, Polly  1779Connecticut, USA I95471 AALT 
291 Hinckley, Patty  1781Connecticut, USA I95583 AALT 
292 Hinckley, Henry  1777Connecticut, USA I95613 AALT 
293 Hinckley, Charlotte  1783Connecticut, USA I95641 AALT 
294 Hills, Truman Clark  1904Connecticut, USA I67207 AALT 
295 Heminway, Sarah  1773Connecticut, USA I34199 AALT 
296 Hemingway, Samuel S  1827Connecticut, USA I9922 AALT 
297 Hemingway, Betsey  1834Connecticut, USA I16369 AALT 
298 Hathaway, Orson B  22 maj 1808Connecticut, USA I43545 AALT 
299 Harvey, Hope R.  1926Connecticut, USA I65660 AALT 
300 Hamlin, Mehitabel  17 nov. 1664Connecticut, USA I143854 AALT 

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»



Død

Match 251 til 276 fra 276

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
251 Belden, Daniel  24 dec. 1759Connecticut, USA I26556 AALT 
252 Beckwith, Thomas  22 okt. 1829Connecticut, USA I72883 AALT 
253 Beckwith, Job  15 dec. 1780Connecticut, USA I72431 AALT 
254 Beach, Mary  1 sep. 1688Connecticut, USA I42281 AALT 
255 Beach, Esther  12 dec. 1772Connecticut, USA I42328 AALT 
256 Bartlett Jr., Samuel Jr.  19 nov. 1746Connecticut, USA I113631 AALT 
257 Barrett, Susannah  4 jan. 1749Connecticut, USA I71285 AALT 
258 Barrett, Phebe  13 jan. 1749Connecticut, USA I72435 AALT 
259 Barden, Sarah  28 feb. 1818Connecticut, USA I73276 AALT 
260 Balch, Thomas  1 jul. 1871Connecticut, USA I62802 AALT 
261 Badger, Sarah  19 jul. 1847Connecticut, USA I29953 AALT 
262 Babcock, Phebe  1841Connecticut, USA I95222 AALT 
263 Babcock, Ezera  Connecticut, USA I33693 AALT 
264 Avery, James  1763Connecticut, USA I75631 AALT 
265 Atwater, Hannah  1825Connecticut, USA I51273 AALT 
266 Atkins, Zilpah  26 jan. 1787Connecticut, USA I28717 AALT 
267 Atkins, Mary  eft. 1760Connecticut, USA I100367 AALT 
268 Arnold, Rhodes  22 jun. 1812Connecticut, USA I74950 AALT 
269 Arnold, Amy  19 sep. 1797Connecticut, USA I74799 AALT 
270 Andrews, Harriet Gordon  24 okt. 1902Connecticut, USA I96427 AALT 
271 Alling, Ebenezer  18 sep. 1734Connecticut, USA I140296 AALT 
272 Allen, Capt. Capt. Thomas  16 maj 1842Connecticut, USA I35825 AALT 
273 Adams, William  21 maj 1821Connecticut, USA I11122 AALT 
274 Adams, Lois  21 maj 1821Connecticut, USA I11013 AALT 
275 Adams, James  Connecticut, USA I11085 AALT 
276 Adams, Elizabeth  20 mar. 1781Connecticut, USA I26706 AALT 

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.