Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 151 til 200 fra 494

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
151 Philo, Elizabeth  1787Connecticut, USA I25687 AALT 
152 Philo, Asahel  1789Connecticut, USA I12304 AALT 
153 Phillips, Riley E.  jul. 1846Connecticut, USA I40356 AALT 
154 Phelps, Sarah  ca. 1632Connecticut, USA I114478 AALT 
155 Phelps, Mehitable  1727Connecticut, USA I126947 AALT 
156 Phelps, Hannah  25 okt. 1693Connecticut, USA I114993 AALT 
157 Phelps, Alexander  1723Connecticut, USA I126942 AALT 
158 Phelps, Abigail  1721Connecticut, USA I127209 AALT 
159 Perkins, Mary C.  1796Connecticut, USA I28770 AALT 
160 Pember, Willys  1784Connecticut, USA I14691 AALT 
161 Pember, Lois  1772Connecticut, USA I14717 AALT 
162 Pember, Jabez  1783Connecticut, USA I14641 AALT 
163 Peet, Abijah  1759Connecticut, USA I93841 AALT 
164 Peck, Ruth  1746Connecticut, USA I57720 AALT 
165 Peat, Abigail  ca. 1744Connecticut, USA I25927 AALT 
166 Payne, James  1700Connecticut, USA I25480 AALT 
167 Parsons, Mary Ann  1816Connecticut, USA I63778 AALT 
168 Parmelee, Carrie Belle  feb. 1860Connecticut, USA I63074 AALT 
169 Parker, Eldad  1794Connecticut, USA I53159 AALT 
170 Palmer, Mary  17 jan. 1847Connecticut, USA I96853 AALT 
171 Palmer, Chloe  13 nov. 1778Connecticut, USA I125667 AALT 
172 Page, Louis H  dec. 1856Connecticut, USA I83702 AALT 
173 Paddock, George  1794Connecticut, USA I12380 AALT 
174 Paddock, Bethia  22 jan. 1729Connecticut, USA I26751 AALT 
175 Osborne, K Gertrude  9 sep. 1884Connecticut, USA I62269 AALT 
176 Norton, Willis Henry  14 jul. 1890Connecticut, USA I67151 AALT 
177 Norton, Henry  apr. 1853Connecticut, USA I67449 AALT 
178 Nichols, Lucy  1775Connecticut, USA I3150 AAP 
179 Newcomb, Lydia  28 apr. 1763Connecticut, USA I121040 AALT 
180 Munson, Henry Hallet  3 feb. 1880Connecticut, USA I78127 AALT 
181 Morse, Caroline  28 sep. 1799Connecticut, USA I24842 AALT 
182 Morgan, Richard Jr.  ca. 1730Connecticut, USA I44819 AALT 
183 Morcus, Helen  10 aug. 1914Connecticut, USA I1361 AAP 
184 Morcus, Bertha  ca. 1908Connecticut, USA I1363 AAP 
185 Moore, William J P  1858Connecticut, USA I65584 AALT 
186 Moore, Roberta E.  feb. 1878Connecticut, USA I65704 AALT 
187 Moore, Mrs Lucy  1829Connecticut, USA I65828 AALT 
188 Monson, Hendrick H.  1846Connecticut, USA I62097 AALT 
189 Mnu, Jerusha  1771Connecticut, USA I42368 AALT 
190 Mitchell, Elizabeth  1620Connecticut, USA I40987 AALT 
191 Mitchell, Basil K  1885Connecticut, USA I68128 AALT 
192 Millard, Abiathar  14 sep. 1760Connecticut, USA I3601 AALT 
193 Miles, Mary  1 mar. 1789Connecticut, USA I13572 AALT 
194 Miles, Jonathan  1791Connecticut, USA I78027 AALT 
195 Miles, Abigail  1793Connecticut, USA I13523 AALT 
196 Merwin, Nathaniel Royal  ml. 1807 og 1808Connecticut, USA I78608 AALT 
197 Merriman, George Isaac  20 feb. 1820Connecticut, USA I72459 AALT 
198 Mead, Katharine Polly  1793Connecticut, USA I29999 AALT 
199 McGowan, Harriet C.  2 sep. 1900Connecticut, USA I63230 AALT 
200 Marshall, Beatrice  1903Connecticut, USA I67894 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Næste»



Død

Match 151 til 200 fra 276

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
151 Hemingway, Samuel S  15 feb. 1871Connecticut, USA I7254 AALT 
152 Hemingway, Samuel S  Connecticut, USA I9922 AALT 
153 Hemingway, Riley J.  17 feb. 1839Connecticut, USA I16476 AALT 
154 Hemingway, Jacob Willis  20 maj 1905Connecticut, USA I28289 AALT 
155 Hemingway, Esther B  3 jun. 1903Connecticut, USA I7307 AALT 
156 Hayes, Joseph  11 dec. 1798Connecticut, USA I86864 AALT 
157 Hayes, Asa  23 feb. 1879Connecticut, USA I87040 AALT 
158 Hawes, Sarah  1747Connecticut, USA I29499 AALT 
159 Haven Hemenway, Elizabeth  22 nov. 1821Connecticut, USA I136339 AALT 
160 Hart, Lena May  1963Connecticut, USA I67235 AALT 
161 Hall, Sarah  5 sep. 1774Connecticut, USA I66316 AALT 
162 Hall, Abel L  1884Connecticut, USA I72389 AALT 
163 Hale, Samuel  20 sep. 1760Connecticut, USA I4662 AALT 
164 Grover, Jerusha  20 feb. 1845Connecticut, USA I66860 AALT 
165 Griswold, John  13 jun. 1738Connecticut, USA I50483 AALT 
166 Greene, Jeremiah  1766Connecticut, USA I5187 AALT 
167 Gray, Anstrase  11 jun. 1785Connecticut, USA I19807 AALT 
168 Graves, Margaret  24 apr. 1831Connecticut, USA I24851 AALT 
169 Graves, Elder Josiah  24 jul. 1825Connecticut, USA I87110 AALT 
170 Goodrich, Joel  1840Connecticut, USA I49294 AALT 
171 Goodrich, Joel  Connecticut, USA I49266 AALT 
172 Goodenough, Priscilla Pauline  25 nov. 1959Connecticut, USA I65847 AALT 
173 Goodenough, Giles Frederick  jan. 1960Connecticut, USA I65816 AALT 
174 Frink, Eunice  30 nov. 1820Connecticut, USA I43673 AALT 
175 Freeman, Sylvanus  29 maj 1776Connecticut, USA I37014 AALT 
176 Franklin, Richard L.  7 sep. 1880Connecticut, USA I81271 AALT 
177 Fenton, Augusta T  23 mar. 1855Connecticut, USA I115870 AALT 
178 Everett, Hannah  3 aug. 1826Connecticut, USA I79102 AALT 
179 Estabrook, Capt Joseph  AfdødConnecticut, USA I11937 AALT 
180 Elwell, Mary  Connecticut, USA I440 AALT 
181 Elwell, Isaac  1799Connecticut, USA I391 AALT 
182 Elwell, Grissel  6 jun. 1816Connecticut, USA I261 AALT 
183 Elwell, Esther  Connecticut, USA I32 AALT 
184 Elwell, Deborah  Connecticut, USA I124432 AALT 
185 Elwell, Angeline  9 maj 1914Connecticut, USA I10700 AALT 
186 Ellsworth, Capt. John  14 jul. 1779Connecticut, USA I11303 AALT 
187 Ellsworth, John  1760Connecticut, USA I108144 AALT 
188 Elliot, Mary  9 mar. 1771Connecticut, USA I143811 AALT 
189 Edwards, Sarah Anne  1662Connecticut, USA I20567 AALT 
190 Durkee, Jeremiah  30 jan. 1734Connecticut, USA I43796 AALT 
191 Dunbar, Joseph  1730Connecticut, USA I74052 AALT 
192 Drake, Lydia  7 maj 1702Connecticut, USA I57527 AALT 
193 Drake, Job  3 apr. 1790Connecticut, USA I107397 AALT 
194 Drake, David  1790Connecticut, USA I103117 AALT 
195 Dodge, John  aug. 1775Connecticut, USA I71835 AALT 
196 Dodd, Edward  1729Connecticut, USA I26983 AALT 
197 Dewolf, Azubah  1800Connecticut, USA I39378 AALT 
198 Denison, Sarah  1800Connecticut, USA I26972 AALT 
199 Denison, Samuel  10 mar. 1792Connecticut, USA I22162 AALT 
200 De Cordova Y Benavides, Maria Joaquina Fernandez  1825Connecticut, USA I118476 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.