Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 101 til 150 fra 494

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
101 Spencer, Child  1793Connecticut, USA I15628 AALT 
102 Spencer, Catherine  1778Connecticut, USA I11394 AALT 
103 Smith, Sally Denison  28 aug. 1779Connecticut, USA I35812 AALT 
104 Smith, Nathaniel Roswell  24 nov. 1778Connecticut, USA I61018 AALT 
105 Smith, Lucretia  1786Connecticut, USA I23757 AALT 
106 Smith, Deborah  1711Connecticut, USA I61683 AALT 
107 Slate Mr.  1720Connecticut, USA I27110 AALT 
108 Siner, Harriett Jane  8 jan. 1910Connecticut, USA I111910 AALT 
109 Siner, Ethel Irma  21 mar. 1906Connecticut, USA I111865 AALT 
110 Shepard, Caleb A.  1818Connecticut, USA I14126 AALT 
111 Shelden, Adeline  1817Connecticut, USA I43799 AALT 
112 Shaw, Rhoda  7 jan. 1790Connecticut, USA I66753 AALT 
113 Shaw, Lydia  1753Connecticut, USA I131239 AALT 
114 Share, John I  ca. 1630Connecticut, USA I3255 AAP 
115 Seymour, Wellington  1816Connecticut, USA I65371 AALT 
116 Seymour, Roswell  1821Connecticut, USA I65796 AALT 
117 Seymour, George  1811Connecticut, USA I136299 AALT 
118 Seymour, Ann Maria  10 jul. 1815Connecticut, USA I65580 AALT 
119 Seymour  1819Connecticut, USA I65635 AALT 
120 Seward, Elizabeth  7 dec. 1734Connecticut, USA I24763 AALT 
121 Sedgwick, Theodore  29 mar. 1837Connecticut, USA I41583 AALT 
122 Sedgwick, Sarah  25 mar. 1739Connecticut, USA I62297 AALT 
123 Sedgwick, Jane  1836Connecticut, USA I65586 AALT 
124 Seaman, Sellinda  1810Connecticut, USA I46873 AALT 
125 Schuetz, Victoria H  5 nov. 1917Connecticut, USA I753 AAP 
126 Schuetz, Robert B  ca. 1928Connecticut, USA I758 AAP 
127 Schuetz, Maxine H  26 jan. 1913Connecticut, USA I754 AAP 
128 Schuetz, Arnold E  18 okt. 1921Connecticut, USA I757 AAP 
129 Schuetz, Anna Irene  22 feb. 1892Connecticut, USA I736 AAP 
130 Russell, Thomas  1687Connecticut, USA I244 AALT 
131 Rude, Mehitable  1772Connecticut, USA I10109 AALT 
132 Rudd, Elisha  1732Connecticut, USA I25919 AALT 
133 Rudd, Betsy Betty  28 jun. 1765Connecticut, USA I10494 AALT 
134 Rose, Jerusha  ca. 1770Connecticut, USA I136333 AALT 
135 Rose, Daniel  1771Connecticut, USA I136332 AALT 
136 Rogers, Thankful  1712Connecticut, USA I49065 AALT 
137 Richards, Moses  1761Connecticut, USA I54080 AALT 
138 Richards, Moses  6 mar. 1733Connecticut, USA I27841 AALT 
139 Rice, Miriam  ca. 1772Connecticut, USA I41767 AALT 
140 Pratt, William Lee  29 aug. 1823Connecticut, USA I118332 AALT 
141 Pratt, Temperance  1704Connecticut, USA I91790 AALT 
142 Pratt, Nathan  7 nov. 1753Connecticut, USA I94694 AALT 
143 Pratt, Maria  1810Connecticut, USA I94520 AALT 
144 Pratt, Henry H.  1847Connecticut, USA I118316 AALT 
145 Pratt, Hannah  1860Connecticut, USA I83291 AALT 
146 Pratt, Charles W  1868Connecticut, USA I86072 AALT 
147 Potter, Merilla  19 dec. 1787Connecticut, USA I28308 AALT 
148 Potter, Joel  9 aug. 1782Connecticut, USA I2880 AAP 
149 Potter, Daniel Woodruff  19 dec. 1787Connecticut, USA I30710 AALT 
150 Picket, Eli  26 apr. 1770Connecticut, USA I88439 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Næste»



Død

Match 101 til 150 fra 276

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
101 Mansfield, Samuel  12 dec. 1705Connecticut, USA I137617 AALT 
102 Manning, Sarah Rose  21 feb. 1918Connecticut, USA I62695 AALT 
103 MacOon, Mary  1784Connecticut, USA I66300 AALT 
104 Mack, Sarah  mar. 1826Connecticut, USA I104277 AALT 
105 Mack, John Lieat  17 okt. 1778Connecticut, USA I87021 AALT 
106 Lynde, Mary Ann  19 dec. 1851Connecticut, USA I110296 AALT 
107 Lupton, Thomas  1660Connecticut, USA I19856 AALT 
108 Lord, Mehitabel  1810Connecticut, USA I61190 AALT 
109 Lord, Mehitabel  1760Connecticut, USA I60927 AALT 
110 Loomis, Ursalah  3 nov. 1820Connecticut, USA I11346 AALT 
111 Loomis, Ruth  17 jun. 1770Connecticut, USA I5201 AALT 
112 Loomis, Hannah  1815Connecticut, USA I5441 AALT 
113 Loomis, Abigail  Connecticut, USA I11383 AALT 
114 Linsly, Ebenezer  8 nov. 1822Connecticut, USA I21252 AALT 
115 Linsley, Marietta  19 dec. 1842Connecticut, USA I25724 AALT 
116 Lindsley, Abigail  9 feb. 1835Connecticut, USA I23881 AALT 
117 Leffingwell, Mary  9 jul. 1764Connecticut, USA I114928 AALT 
118 Lee, Laura L  24 aug. 1887Connecticut, USA I34007 AALT 
119 Knowles, Mercy  5 jun. 1732Connecticut, USA I35303 AALT 
120 Knowles, Cornelius  28 dec. 1764Connecticut, USA I35278 AALT 
121 Knight, Rachel  24 nov. 1744Connecticut, USA I72917 AALT 
122 Kneeland, Phebe  26 apr. 1793Connecticut, USA I61031 AALT 
123 Knapp, Charity  jan. 1815Connecticut, USA I4928 AALT 
124 Kingsbury, Irena  13 feb. 1803Connecticut, USA I55730 AALT 
125 Kimball, Elizabeth  Connecticut, USA I60243 AALT 
126 Kimball, Elijah  4 nov. 1788Connecticut, USA I95177 AALT 
127 Kenyon, Phebe Caroline  2 nov. 1896Connecticut, USA I82899 AALT 
128 Keeler, Sarah  1756Connecticut, USA I47279 AALT 
129 Judd, Nancy  27 okt. 1927Connecticut, USA I65786 AALT 
130 Judd, Mercy  27 apr. 1826Connecticut, USA I9048 AALT 
131 Jones, Hannah  1686Connecticut, USA I21630 AALT 
132 Johnson, Ruth  11 dec. 1728Connecticut, USA I19381 AALT 
133 Hull, Wyllys Deacon  8 maj 1839Connecticut, USA I117607 AALT 
134 Hull, Sarah  1 feb. 1796Connecticut, USA I117807 AALT 
135 Hubbard, Sarah  1693Connecticut, USA I18548 AALT 
136 Hubbard, Edmund  1825Connecticut, USA I94612 AALT 
137 Hubbard, Aaron  ca. 1824Connecticut, USA I94634 AALT 
138 Howe, Sarah  1761Connecticut, USA I43910 AALT 
139 Hosmer, Ashbel  2 apr. 1812Connecticut, USA I79257 AALT 
140 Hooker, Samuel  6 aug. 1825Connecticut, USA I143659 AALT 
141 Hooker, Hannah  21 maj 1797Connecticut, USA I143821 AALT 
142 Holbrook, Mary  3 apr. 1745Connecticut, USA I93936 AALT 
143 Hogarty, Mary Emily  17 aug. 1910Connecticut, USA I96219 AALT 
144 Hodge, Richard  1687Connecticut, USA I18299 AALT 
145 Hodge, Rhoda  10 aug. 1784Connecticut, USA I5300 AALT 
146 Hodge, Phoebe  eft. 1850Connecticut, USA I109 AALT 
147 Hoadley, Mary Ann  31 mar. 1893Connecticut, USA I136303 AALT 
148 Hill, Elizabeth  1662Connecticut, USA I61657 AALT 
149 Hester, Terresa J  1 nov. 1893Connecticut, USA I48338 AALT 
150 Hemingway, Willis J.  4 nov. 1931Connecticut, USA I14814 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»



Ægteskab

Match 101 til 101 fra 101

«Forrige 1 2 3

   Familie    Ægteskab    Familie-ID   Træ 
101 Andros / Sampson  1779Connecticut, USA F30509 AALT 

«Forrige 1 2 3



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.