Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 451 til 494 fra 494

«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
451 Tuttle, Osman B  1840Connecticut, USA I42819 AALT 
452 Tuttle, Paul Whitney  14 jul. 1908Connecticut, USA I75309 AALT 
453 Tuttle, William S  1832Connecticut, USA I42460 AALT 
454 Wadsworth, Chauncey  1797Connecticut, USA I3155 AAP 
455 Wadsworth, Frederick  1796Connecticut, USA I3162 AAP 
456 Wadsworth, Horace  1772Connecticut, USA I3148 AAP 
457 Wadsworth, Jared  1776Connecticut, USA I3147 AAP 
458 Wadsworth, Oliver  ca. 1800Connecticut, USA I3167 AAP 
459 Wadsworth, Samuel  1799Connecticut, USA I3153 AAP 
460 Wallace, Barbara Manning  24 maj 1900Connecticut, USA I63050 AALT 
461 Wargo, Helen E.  1912Connecticut, USA I65630 AALT 
462 Warner, Henry  21 aug. 1689Connecticut, USA I13744 AALT 
463 Wasson, John  9 maj 1759Connecticut, USA I21442 AALT 
464 Watson, Barbara Osborne  1914Connecticut, USA I65555 AALT 
465 Watson, Isabel Sedgwick  7 jun. 1831Connecticut, USA I65799 AALT 
466 Watson, Louisa E.  2 mar. 1841Connecticut, USA I65401 AALT 
467 Watson, Sarah Eliza  26 feb. 1829Connecticut, USA I126333 AALT 
468 Watson, Seymour  19 jun. 1838Connecticut, USA I65760 AALT 
469 Webb, Josiah  15 mar. 1707Connecticut, USA I28988 AALT 
470 Webster, Ellsworth  1797Connecticut, USA I11746 AALT 
471 Webster, Polly  1799Connecticut, USA I11866 AALT 
472 Wheeler, Clarinda C.  1798/1803Connecticut, USA I127848 AALT 
473 Wheeler, Edmund  22 jul. 1800Connecticut, USA I46811 AALT 
474 Wheeler, Merrill  ca. 1807Connecticut, USA I112553 AALT 
475 Wheeler, William  ca. 1798Connecticut, USA I112556 AALT 
476 Wightman, Lucy  17 maj 1772Connecticut, USA I125920 AALT 
477 Wightman, Sarah  2 jan. 1778Connecticut, USA I125925 AALT 
478 Wightman, William D  1775Connecticut, USA I46681 AALT 
479 Wilcox, Elizabeth M  1 apr. 1824Connecticut, USA I84812 AALT 
480 Wilcox, Mary  1765Connecticut, USA I127806 AALT 
481 Williams, Ephraim  30 dec. 1850Connecticut, USA I75172 AALT 
482 Williams, Julia E.  9 mar. 1862Connecticut, USA I60916 AALT 
483 Williams, Mary  1804Connecticut, USA I38864 AALT 
484 Wood, Rhoda  26 jan. 1781Connecticut, USA I2869 AAP 
485 Wood, Mrs. Sophia  1776Connecticut, USA I2870 AAP 
486 Woodruff, Hezekiah  9 aug. 1701Connecticut, USA I76854 AALT 
487 Yale, Fred Thomas Jr  31 maj 1879Connecticut, USA I74418 AALT 
488 Yale, Helen C  17 jul. 1910Connecticut, USA I74459 AALT 
489 Yale, Son  1886Connecticut, USA I63080 AALT 
490 Yeoman, Mehetable  1 apr. 1707Connecticut, USA I8799 AALT 
491 Yeoman, Moses  1708Connecticut, USA I8383 AALT 
492 Yeoman, Sarah  21 mar. 1700Connecticut, USA I8560 AALT 
493 Yeomans, Sarah  1717Connecticut, USA I59674 AALT 
494 Young, Orrin  ca. 1822Connecticut, USA I84512 AALT 

«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.