Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 251 til 300 fra 494

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
251 Judd, Chester S  1784Connecticut, USA I99077 AALT 
252 Judd, Elihu  7 dec. 1790Connecticut, USA I51894 AALT 
253 Judd, Eliza  14 maj 1795Connecticut, USA I45329 AALT 
254 Judd, Nancy  21 okt. 1927Connecticut, USA I65786 AALT 
255 Keeler, Julia  1840Connecticut, USA I29200 AALT 
256 Keith, Barbara  eft. 1774Connecticut, USA I43534 AALT 
257 Keith, Daniel  1793Connecticut, USA I43496 AALT 
258 Keith, Elizabeth  eft. 1774Connecticut, USA I43694 AALT 
259 Keith, Roswell  1784Connecticut, USA I43546 AALT 
260 Kerr, Henry Stewart  1904Connecticut, USA I67231 AALT 
261 Kettle, Allen  1857Connecticut, USA I96561 AALT 
262 Kettle, George L.  1853Connecticut, USA I96487 AALT 
263 Kettle, John Quincy  1861Connecticut, USA I96438 AALT 
264 Kettle, William B.  1858Connecticut, USA I96407 AALT 
265 Kettle, William S  ca. 1831Connecticut, USA I96436 AALT 
266 Kimball, Abram  ca. 1800Connecticut, USA I17748 AALT 
267 Kimberly, Julia E.  27 dec. 1851Connecticut, USA I43006 AALT 
268 Kingsley, Eleanor Mariah  28 jan. 1813Connecticut, USA I108920 AALT 
269 Kingsley, Harriet  3 mar. 1814Connecticut, USA I108918 AALT 
270 Kirtland, Edwin  1847Connecticut, USA I38419 AALT 
271 Kirtland, Lucy F.  3 apr. 1793Connecticut, USA I79475 AALT 
272 Kirtland, Maria Foote  1841Connecticut, USA I38310 AALT 
273 Lamphere, Leonard  1707Connecticut, USA I119862 AALT 
274 Lamphere, S  ca. 1782Connecticut, USA I39744 AALT 
275 Lancraft, Mary  ca. 1769Connecticut, USA I117616 AALT 
276 Lane, Edith Frances  19 apr. 1860Connecticut, USA I62559 AALT 
277 Lane, Florence Carrington  5 maj 1856Connecticut, USA I62663 AALT 
278 Lane, Phelps Allyn  27 dec. 1934Connecticut, USA I63144 AALT 
279 Lanzano, Dora  17 okt. 1925Connecticut, USA I913 AAP 
280 Lanzano, Liberty  ca. 1924Connecticut, USA I912 AAP 
281 Lanzano, Mary  ca. 1919Connecticut, USA I924 AAP 
282 Lathrop, Elizabeth  1648Connecticut, USA I75194 AALT 
283 Lathrop, Mary Polly  9 jan. 1776Connecticut, USA I74544 AALT 
284 Lathrop, Sarah  1752Connecticut, USA I29595 AALT 
285 Laurence, Mary Townley  1741Connecticut, USA I139772 AALT 
286 Lobdell, Esther  7 apr. 1792Connecticut, USA I25005 AALT 
287 Loomis, Jerusha Brewster  14 apr. 1807Connecticut, USA I136335 AALT 
288 Loomis, Martha Wadsworth  26 okt. 1813Connecticut, USA I136334 AALT 
289 Lord, Ephraim  1709Connecticut, USA I60771 AALT 
290 Lynde, William Hart  1797Connecticut, USA I110292 AALT 
291 Lyon, Enoch L  1836Connecticut, USA I134418 AALT 
292 MacOon, Mary  1690Connecticut, USA I66300 AALT 
293 Markham, Daniel  1778Connecticut, USA I31635 AALT 
294 Markham, William  1777Connecticut, USA I31646 AALT 
295 Marshall, Beatrice  1903Connecticut, USA I67894 AALT 
296 McGowan, Harriet C.  2 sep. 1900Connecticut, USA I63230 AALT 
297 Mead, Katharine Polly  1793Connecticut, USA I29999 AALT 
298 Merriman, George Isaac  20 feb. 1820Connecticut, USA I72459 AALT 
299 Merwin, Nathaniel Royal  ml. 1807 og 1808Connecticut, USA I78608 AALT 
300 Miles, Abigail  1793Connecticut, USA I13523 AALT 

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»



Død

Match 251 til 276 fra 276

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
251 Starr, Fanny  20 aug. 1838Connecticut, USA I40336 AALT 
252 Steele, Martha  jan. 1712Connecticut, USA I3238 AAP 
253 Stevens, Esther  1765Connecticut, USA I191 AALT 
254 Stevens, Mabel  1765Connecticut, USA I363 AALT 
255 Stevens, Mary  1765Connecticut, USA I110 AALT 
256 Stoddard, Mary Ann  3 apr. 1877Connecticut, USA I41406 AALT 
257 Stowell, Sarah  1829Connecticut, USA I93843 AALT 
258 Taber, Amelia  14 jan. 1839Connecticut, USA I35904 AALT 
259 Talmadge, Kezia  1737Connecticut, USA I57875 AALT 
260 Tanner, Emma C.  Connecticut, USA I80641 AALT 
261 Tanner, Luther S.  1927Connecticut, USA I80674 AALT 
262 Tanner, Susan Mercelia  12 jun. 1856Connecticut, USA I13600 AALT 
263 Tanner, William Warren  23 aug. 1911Connecticut, USA I80570 AALT 
264 Thompson, John  14 okt. 1688Connecticut, USA I32185 AALT 
265 Throop, William  13 jul. 1857Connecticut, USA I47288 AALT 
266 Ward, Ambrose  14 nov. 1739Connecticut, USA I42481 AALT 
267 Ward, Deborah  Connecticut, USA I42324 AALT 
268 Ward, Diantha  1771Connecticut, USA I21936 AALT 
269 Ward, Rebecca  2 apr. 1825Connecticut, USA I42484 AALT 
270 Warner, Phebe  23 jun. 1782Connecticut, USA I2709 AAP 
271 Watson, Edmund  11 sep. 1883Connecticut, USA I62193 AALT 
272 Welles, Mary  1647Connecticut, USA I33463 AALT 
273 Wilcox, Stephen  15 apr. 1828Connecticut, USA I117897 AALT 
274 Williams, Edward  5 jun. 1824Connecticut, USA I75283 AALT 
275 Williams, Hannah  eft. 4 okt. 1749Connecticut, USA I94608 AALT 
276 Woodward, Hannah  1801Connecticut, USA I9196 AALT 

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.