Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 451 til 494 fra 494

«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
451 McGowan, Harriet C.  2 sep. 1900Connecticut, USA I63230 AALT 
452 Goodenough, Frieda M  1903Connecticut, USA I65408 AALT 
453 Honor, Josephine  1903Connecticut, USA I67304 AALT 
454 Hubbell, Mabel T.  1903Connecticut, USA I63251 AALT 
455 Marshall, Beatrice  1903Connecticut, USA I67894 AALT 
456 Bristol, Sarah Elizabeth  1904Connecticut, USA I67215 AALT 
457 Goodenough, Barbara A  1904Connecticut, USA I65825 AALT 
458 Hills, Truman Clark  1904Connecticut, USA I67207 AALT 
459 Kerr, Henry Stewart  1904Connecticut, USA I67231 AALT 
460 Siner, Ethel Irma  21 mar. 1906Connecticut, USA I111865 AALT 
461 Morcus, Bertha  ca. 1908Connecticut, USA I1363 AAP 
462 Brainard, Mary Louise  23 mar. 1908Connecticut, USA I63523 AALT 
463 Tuttle, Paul Whitney  14 jul. 1908Connecticut, USA I75309 AALT 
464 Bidwell, Ruth Wagner  18 sep. 1908Connecticut, USA I67402 AALT 
465 Barnes, Marjorie  1909Connecticut, USA I67437 AALT 
466 Barnes, Wilbur J  1909Connecticut, USA I67333 AALT 
467 Goodenough, Virginia A  1909Connecticut, USA I65848 AALT 
468 Brown, Allyn M  1910Connecticut, USA I65622 AALT 
469 Siner, Harriett Jane  8 jan. 1910Connecticut, USA I111910 AALT 
470 Davis, Elizabeth  5 mar. 1910Connecticut, USA I99733 AALT 
471 Yale, Helen C  17 jul. 1910Connecticut, USA I74459 AALT 
472 Goodenough, Arthur Griswold  27 apr. 1911Connecticut, USA I65940 AALT 
473 Wargo, Helen E.  1912Connecticut, USA I65630 AALT 
474 Schuetz, Maxine H  26 jan. 1913Connecticut, USA I754 AAP 
475 Watson, Barbara Osborne  1914Connecticut, USA I65555 AALT 
476 Morcus, Helen  10 aug. 1914Connecticut, USA I1361 AAP 
477 Friend, Bernice J.  4 jan. 1915Connecticut, USA I63406 AALT 
478 Davis, Faith L  28 aug. 1917Connecticut, USA I99748 AALT 
479 Schuetz, Victoria H  5 nov. 1917Connecticut, USA I753 AAP 
480 Crotty, John (Jacky)  21 jul. 1918Connecticut, USA I82391 AALT 
481 Lanzano, Mary  ca. 1919Connecticut, USA I924 AAP 
482 Schuetz, Arnold E  18 okt. 1921Connecticut, USA I757 AAP 
483 Hall, Catherine L  1924Connecticut, USA I63401 AALT 
484 Lanzano, Liberty  ca. 1924Connecticut, USA I912 AAP 
485 Lanzano, Dora  17 okt. 1925Connecticut, USA I913 AAP 
486 Barnes, Howard  1926Connecticut, USA I67308 AALT 
487 Hall, Gertrude Ellen  1926Connecticut, USA I63340 AALT 
488 Harvey, Hope R.  1926Connecticut, USA I65660 AALT 
489 Hall, David S  1927Connecticut, USA I63180 AALT 
490 Judd, Nancy  21 okt. 1927Connecticut, USA I65786 AALT 
491 Schuetz, Robert B  ca. 1928Connecticut, USA I758 AAP 
492 Lane, Phelps Allyn  27 dec. 1934Connecticut, USA I63144 AALT 
493 Tollman, Marion C  1939Connecticut, USA I139761 AALT 
494 Tollman, Marion C  1939Connecticut, USA I69106 AALT 

«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.